Actos BORME de Colorker Sociedad Anonima
22 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: PARRA RIBES LUIS. Aud.Supl.: ROCA MONFORT JULIO. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 205, S 8, HCS 1361, I/A 73 (15.11.21).
15 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL. Presidente: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL.Con.Delegado: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL. Consejero: DEBON VICENT RAMON. Nombramientos. Consejero:OLLIRUM 2021 SOCIEDAD LIMITADA;NULMAN 2021 SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: OLLIRUM 2021 SOCIEDAD LIMITADA.Con.Delegado: OLLIRUM 2021 SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 204, S 8, H CS 1361, I/A 71 ( 9.09.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: DEBON VICENT RAMON. Nombramientos. Apoderado: NULMAN 2021 SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 1764, L 1325, F 205, S 8, H CS 1361, I/A 72 ( 9.09.21).
26 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.C.C: AGUILELLA LLINARES JORGE. Nombramientos.Aud.C.Con.: PARRA RIBES LUIS. Aud.Supl.C.C: ROCA MONFORT JULIO. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 204, S 8, H CS1361, I/A 70 (19.11.20).
06 de Agosto de 2020Reelecciones. Consejero: HAMZE KHADDAJ RAMI;DEBON VICENT RAMON;SANCHEZ FAYOS MANUEL;MURILLO FERNANDEZMANUEL ANGEL;LATORRE IBAÑEZ VICENTE;CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;JARQUE GIMENO LUIS. Presidente: MURILLOFERNANDEZ MANUEL ANGEL. Secretario: SANCHEZ FAYOS MANUEL. Con.Delegado: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL.Datos registrales. T 1764, L 1325, F 204, S 8, H CS 1361, I/A 69 (22.07.20).
17 de Marzo de 2020Nombramientos. Consejero: HAMZE KHADDAJ RAMI. Ampliación de capital. Suscrito: 419.500,00 Euros. Desembolsado:419.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.194.250,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.194.250,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales, por aumento de capital . Datos registrales.T 1764, L 1325, F 203, S 8, H CS 1361, I/A 68 ( 5.03.20).
05 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GALVEZ MIGUEL. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 203, S 8, H CS 1361, I/A 67(23.11.18).
25 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.: AGUILELLA LLINARES JORGE. Nombramientos. Auditor:PARRA RIBES LUIS. Aud.Supl.: ROCA MONFORT JULIO. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 203, S 8, H CS 1361, I/A 66(18.09.18).
02 de Agosto de 2018Modificaciones estatutarias. modificacion articulo 17. Datos registrales. T 508, L 75, F 7, S 8, H CS 1361, I/A 61 (25.07.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;SANCHEZ FAYOS MANUEL. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 202, S 8,H CS 1361, I/A 62 (25.07.18).
Nombramientos. Apoderado: JARQUE GIMENO LUIS. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 202, S 8, H CS 1361, I/A 63 (25.07.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 202, S 8, H CS 1361, I/A 64(25.07.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ GALVEZ MIGUEL. Datos registrales. T 1764, L 1325, F 203, S 8, H CS 1361, I/A 65(25.07.18).
11 de Mayo de 2018Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADO por cambio de domicilio.. Cambio de domicilio social. PTDAELS PLANS S/N - POLIGONO INDUSTRIAL ELS PLANS (CHILCHES). Datos registrales. T 508, L 75, F 7, S 8, H CS 1361, I/A 60(30.04.18).
27 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 508, L 75, F 7, S
Reelecciones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.C.C: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 508, L75, F 7, S 8, H CS 1361, I/A 59 (13.01.16).
15 de Septiembre de 2015Reelecciones. Consejero: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL;SANCHEZ FAYOS MANUEL;GONZALEZ GALVEZMIGUEL;LATORRE IBAÑEZ VICENTE;JARQUE GIMENO LUIS;CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;DEBON VICENT RAMON. Presidente:MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL. Secretario: SANCHEZ FAYOS MANUEL. Con.Delegado: MURILLO FERNANDEZMANUEL ANGEL. Datos registrales. T 508, L 75, F 7, S 8, H CS 1361, I/A 57 ( 9.09.15).
Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 17º de los Estatutos Sociales por gratuidad del cargo del administrador. Datosregistrales. T 508, L 75, F 7, S 8, H CS 1361, I/A 56 ( 9.09.15).
18 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apoderado: DIAZ MUÑOZ LINO PEDRO. Apo.Manc.: DIAZ MUÑOZ LINO PEDRO. Datos registrales. T 508, L 75, F6, S 8, H CS 1361, I/A 55 ( 5.12.14).
29 de Mayo de 2014Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 257.750,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Semodifica el artículo 5º de los estatutos sociales, al verificar el desembolso total del capital social.. Otros conceptos: PORESCRITURA otorgada en Castellón el día 27 de Febrero de 2014, ante el Notario Don José Vicente Malo Concepción con número 615de su protocolo, SE SUBSANA la inscripción 43& en cuanto al desembolso de Capital Social y redacción del Artículo 5º de losestatutos sociales. Datos registrales. T 508, L 75, F 6, S 8, H CS 1361, I/A 54 (20.05.14).
26 de Mayo de 2014Nombramientos. M.Com.Ejec: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL;CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;DEBON VICENTRAMON;SANCHEZ FAYOS MANUEL. Modificaciones estatutarias. mod. articulo 7. mod. ar. 17. Artículo de los estatutos: cambio
Revocaciones. Apoderado: CASCOS CABALLERO MAXIMIANO;ROBLEDO MATA AGUSTIN;GONZALEZ MATA MIGUEL;CRESPOZAMORANO FULGENCIO. Apo.Manc.: LLEONART RAMBLA VICTOR. Apoderado: MARTIN VILLARRUBIA EMILIANO;LATORREIBAÑEZ VICENTE. Datos registrales. T 508, L 75, F 6, S 8, H CS 1361, I/A 53 (19.05.14).
09 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 508, L 75, F 5, S8, H CS 1361, I/A 50 (24.12.12).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.C.C: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 508, L75, F 5, S 8, H CS 1361, I/A 51 (24.12.12).
14 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTIN VILLARRUBIA EMILIANO. Datos registrales. T 508, L 75, F 5, S 8, H CS 1361, I/A 49 (2.08.12).
05 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;DEBON VICENT RAMON;SANCHEZ FAYOS MANUEL. Datosregistrales. T 508, L 75, F 4, S 8, H CS 1361, I/A 45 (25.08.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ GALVEZ MIGUEL;LATORRE IBAÑEZ VICENTE;CRESPO GAMIZ ROCIO;GONZALVEZALBERTOS RICARDO;DIAZ MUÑOZ LINO PEDRO. Datos registrales. T 508, L 75, F 4, S 8, H CS 1361, I/A 46 (25.08.11).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ MUÑOZ LINO PEDRO. Datos registrales. T 508, L 75, F 4, S 8, H CS 1361, I/A 47 (25.08.11).
Revocaciones. Apoderado: MARTIN VILLARRUBIA EMILIANO. Apo.Manc.: CASCOS CABALLERO MAXIMIANO;LATORRE IBAÑEZVICENTE;GONZALEZ GALVEZ MIGUEL;GOZALVEZ ALBERTOS RICA;CASCOS CABALLERO MAXIMIANO;LATORRE IBAÑEZVICENTE;GONZALEZ GALVEZ MIGUEL. Apoderado: GONZALEZ GALVEZ MIGUEL. Datos registrales. T 508, L 75, F 5, S 8, H CS1361, I/A 48 (25.08.11).
02 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MURILLO RUIZ MANUEL. Presidente: MURILLO RUIZ MANUEL. Consejero: LATORRE IBAÑEZVICENTE. Secretario: LATORRE IBAÑEZ VICENTE. Consejero: CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;LLEONART RAMBLAVICTOR;GONZALEZ GALVEZ MIGUEL;DEBON VICENT RAMON;ROBLEDO MATA AGUSTIN;JARQUE GIMENO LUIS.Con.Delegado: MURILLO RUIZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL;LATORREIBAÑEZ VICENTE;CASCOS IBAÑEZ BENJAMIN;GONZALEZ GALVEZ MIGUEL;DEBON VICENT RAMON;SANCHEZ FAYOSMANUEL;JARQUE GIMENO LUIS. Presidente: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL. Secretario: SANCHEZ FAYOS MANUEL.Con.Delegado: MURILLO FERNANDEZ MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 488, L 55, F 145, S 8, H CS 1361, I/A 44 (21.10.10).
15 de Octubre de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado: 1.742.236,88 Euros. Resultante Suscrito: 3.774.750,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.516.986,88 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ampliacion capital. mod. art..Datos registrales. T 488, L 55, F 145, S 8, H CS 1361, I/A 43 ( 5.10.10).
18 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: LLEONART RAMBLA VICTOR. Datos registrales. T 488, L 55, F 145, S 8, H CS 1361, I/A 42 (10.11.09).
03 de Noviembre de 2009Nombramientos. Aud.Supl.: AGUILELLA LLINARES JORGE. Reelecciones. Auditor: ROCA MONFORT JULIO. Datos registrales.T 488, L 55, F 144, S 8, H CS 1361, I/A 40 (20.10.09).
29 de Octubre de 2009Nombramientos. Aud.Supl.CC: AGUILELLA LLINARES JORGE. Reelecciones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Datosregistrales. T 488, L 55, F 145, S 8, H CS 1361, I/A 41 (20.10.09).
06 de Febrero de 2009Ampliación de capital. Suscrito: 1.249.750,00 Euros. Desembolsado: 1.249.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.774.750,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.774.750,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 5º delos Estatutos por ampliación del capital social. Datos registrales. T 488, L 55, F 144, S 8, H CS 1361, I/A 39 (28.01.09).
14 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.CC: ROMERO BELTRAN MARIA ANGELES. Nombramientos.Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Su.C.Con: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 488, L 55, F 144, S 8, HCS 1361, I/A 36 ( 5.01.09).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Su.C.Con: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 488, L55, F 144, S 8, H CS 1361, I/A 37 ( 5.01.09).
Reelecciones. Aud.C.Con.: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Su.C.Con: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 488, L55, F 144, S 8, H CS 1361, I/A 38 ( 5.01.09).