Actos BORME de Comarcal De Materiales De Construccion Sl
13 de Junio de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: AGUAS PARIS JESUS. Nombramientos. ADM.UNICO: PRIETO SERRAVI脩ALS SONIA. Datosregistrales. T 44504 , F 142, S 8, H B 261076, I/A 15 ( 6.06.18).
19 de Febrero de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: RIOSALIDO NU脩EZ ANGELES MARIA. Nombramientos. ADM.UNICO: AGUAS PARIS JESUS.Datos registrales. T 44504 , F 141, S 8, H B 261076, I/A 14 (12.02.18).
22 de Abril de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: PRIETO GALVEZ ANTONIO. Datos registrales. T 44504 , F 141, S 8, H B 261076, I/A 13(14.04.15).
12 de Noviembre de 2014Revocaciones. ADM.UNICO: PRIETO SERRAVI脩ALS SONIA. Nombramientos. ADM.UNICO: RIOSALIDO NU脩EZ ANGELESMARIA. Modificaciones estatutarias. ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 35252 , F 187, S 8, H B 261076, I/A 12 ( 3.11.14).
31 de Enero de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: MARON DE MIGUEL OSCAR. Datos registrales. T 35252 , F 187, S 8, H B 261076, I/A 11(23.01.14).
08 de Agosto de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 204.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 310.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 19.-DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datos registrales. T 35252 ,F 186, S 8, H B 261076, I/A 10 ( 1.08.13).
23 de Diciembre de 2010Revocaciones. ADM.UNICO: PRIETO GALVEZ ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: PRIETO SERRAVI脩ALS SONIA. Datosregistrales. T 35252 , F 186, S 8, H B 261076, I/A 9 (10.12.10).
15 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 106.000,00 Euros. Datos registrales. T 35252 , F 185, S 8, HB 261076, I/A 8 ( 3.09.09).