Actos BORME de Comatol Sociedad Limitada
24 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES MORALES BENITO;SIERRA ARRATE ROBERTO. Secretario: MORALES MORALESBENITO. Presidente: OLIVARES FERNANDEZ JAVIER. Nombramientos. Secretario: OLIVARES FERNANDEZ JAVIER. Consejero:HUERGA SIERRA UNAI;ARAUCUA ZABALA MANUEL. Presidente: ARAUCUA ZABALA MANUEL. Datos registrales. T 3549 , F 12,S 8, H BI 19508, I/A 8 (12.05.21).
06 de Octubre de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERCOMA SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 3549 , F 9, S 8, H BI19508, I/A 7 ( 2.10.17).
13 de Diciembre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 88.635,48 Euros. Resultante Suscrito: 758.774,52 Euros. Datos registrales. T 3549 , F 9,S 8, H BI 19508, I/A 6 (28.11.16).
08 de Octubre de 2014Nombramientos. Consejero: OLIVARES FERNANDEZ JAVIER;MORALES MORALES BENITO;SIERRA ARRATE ROBERTO.Presidente: OLIVARES FERNANDEZ JAVIER. Secretario: MORALES MORALES BENITO. Cambio de domicilio social. BARRIOUGARTE S/N (MUXIKA). Datos registrales. T 3549 , F 8, S 8, H BI 19508, I/A 5 (30.09.14).
13 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRASCO ARRIEN JOSE ASTERIO;CORTAZAR LEON RAMON;MARTIN PEREDA JULIO.Presidente: CARRASCO ARRIEN JOSE ASTERIO. Secretario: CORTAZAR LEON RAMON. Datos registrales. T 3549 , F 8, S 8, HBI 19508, I/A 4 ( 6.08.14).
12 de Junio de 2009Reapertura hoja registral. Datos registrales. T 3549 , F 8, S 8, H BI 19508, I/A 3 M (28.05.09).
28 de Abril de 2009Cierre provisional hoja registral art. 137.2 Ley 43/1995 Impuesto de Sociedades. Datos registrales. T 3549 , F 8, S 8, H BI 19508,I/A 3 H (26.03.09).