Actos BORME de Comco Sa
26 de Mayo de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1137 , F 190, S 8, H GI 3986, I/A 37 (18.05.21).
15 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: ROLAND CARRAGE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: OSCAR GOMEZ FONTES. Nombramientos.Presidente: PASCALE JOLIMAITRE. Apoderado: PASCALE JOLIMAITRE. Apo.Man.Soli: OSCAR GOMEZ FONTES;ALFREDOSANCHEZ MARQUETA. Apo.Sol.: BENOIT JEAN GEORGES ROLAND SAUTEREAU. Modificaciones estatutarias. Se establecemodificar el sistema de convocatoria de la Junta General. Cambio de domicilio social. C/ CADI 12 - NAVES 3-4. POLIGONOINDUSTRIAL (CELRA). Datos registrales. T 1137 , F 188, S 8, H GI 3986, I/A 36 ( 8.01.21).
09 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: OSCAR GOMEZ FONTES. Reelecciones. Consejero: ROLAND CARRAGE. Presidente: ROLANDCARRAGE. Consejero: OSCAR GOMEZ FONTES;PASCALE JOLIMAITRE;POL JOHO. SecreNoConsj: JORDI ARDERIU TURON.Datos registrales. T 1137 , F 188, S 8, H GI 3986, I/A 35 ( 2.10.19).
17 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: MARTA NOGUER ROMERO;OSCAR GOMEZ FONTES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: OSCARGOMEZ FONTES. Datos registrales. T 1137 , F 187, S 8, H GI 3986, I/A 34 (10.12.18).
18 de Octubre de 2017Cambio de domicilio social. C/ CADI 3 - POLIGON INDUSTRIAL (CELRA). Datos registrales. T 1137 , F 187, S 8, H GI 3986, I/A33 (10.10.17).
09 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1137 , F 187, S 8, H GI 3986, I/A 32 ( 2.10.17).
26 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JEAN LUC JOLIMAITRE. Presidente: JEAN LUC JOLIMAITRE. Con.Delegado: JEAN LUCJOLIMAITRE. Consejero: MURIEL BANON;ROLAND CARRAGE. Secretario: JORDI ARDERIU TURON. Nombramientos.Consejero: ROLAND CARRAGE. Presidente: ROLAND CARRAGE. Consejero: OSCAR GOMEZ FONTES. Vicepresid.: OSCARGOMEZ FONTES. Consejero: PASCALE JOLIMAITRE;POL JOHO. SecreNoConsj: JORDI ARDERIU TURON. Datos registrales. T821 , F 24, S 8, H GI 3986, I/A 30 (22.09.14).
Revocaciones. Apoderado: JEAN LUC JOLIMAITRE. Nombramientos. Apoderado: ROLAND CARRAGE. Datos registrales. T1137 , F 187, S 8, H GI 3986, I/A 31 (22.09.14).
08 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 821 , F 24, S 8, H GI 3986, I/A 29 ( 4.11.13).
10 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 821 , F 24, S 8, H GI 3986, I/A 28 (2.01.13).
23 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: RAFAEL GOMEZ DE MEMBRILLERA DOLSET. Nombramientos. Secretario: JORDI ARDERIUTURON. Reelecciones. Presidente: JEAN LUC JOLIMAITRE. Con.Delegado: JEAN LUC JOLIMAITRE. Consejero: MURIELBANON;ROLAND CARRAGE. Datos registrales. T 821 , F 23, S 8, H GI 3986, I/A 27 (11.03.11).
26 de Agosto de 2010Nombramientos. Consejero: MURIEL BANON;ROLAND CARRAGE. Datos registrales. T 821 , F 23, S 8, H GI 3986, I/A 26(17.08.10).
01 de Abril de 2009Cambio de domicilio social. CTRA CRUCE NACIONAL II S/N (CALDES DE MALAVELLA). Datos registrales. T 821 , F 23, S 8, HGI 3986, I/A 25 (23.03.09).