Buscador CIF Logo

Actos BORME Comer Bien Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Comer Bien Sl

Actos BORME Comer Bien Sl - B50469584

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Comer Bien Sl con CIF B50469584

馃敊 Perfil de Comer Bien Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Comer Bien Sl

11 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA MORENO LUCIA. Datos registrales. T 4389 , F 36, S 8, H Z 2145, I/A 38 ( 3.08.23).

04 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MIRAS MASSAGUER IGNACIO;ROVIRA FERRER DAVID. Nombramientos. Adm. Unico:CATERING ARCASA SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador煤nico. Datos registrales. T 4389 , F 36, S 8, H Z 2145, I/A 37 (29.03.23).

01 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: ARQUES GIRBAU ARTUR;ROVIRA FERRER DAVID. Apo.Manc.: LORENTE TARDIO MARIA DELCARMEN;GARCIA MORENO LUCIA. Nombramientos. Apo.Sol.: ROVIRA FERRER DAVID;MIRAS MASSAGUER IGNACIO.Apo.Manc.: LORENTE TARDIO MARIA DEL CARMEN;GARCIA MORENO LUCIA. Datos registrales. T 4389 , F 34, S 8, H Z 2145,I/A 36 (23.02.23).

24 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ARQUES GIRBAU ARTUR. Nombramientos. Adm. Mancom.: MIRAS MASSAGUER IGNACIO.Datos registrales. T 4389 , F 34, S 8, H Z 2145, I/A 34 (17.02.23).

Reelecciones. Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 4389 , F 34, S 8, H Z 2145, I/A 35 (17.02.23).

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: CABRERA SAUQUILLO JAVIER. Datos registrales. T 4389 , F 34, S 8, H Z 2145, I/A 33 (30.09.22).

13 de Enero de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARQUES GIRBAU ARTUR;POLVERINO MAURIZIO. Apo.Manc.: LORENTE TARDIO MARIA DELCARMEN;RUIZ SANCHO ANGELES;LORENTE TARDIO MARIA DEL CARMEN;ROVIRA FERRER DAVID. Apo.Man.Soli: GARCIAMORENO LUCIA. Nombramientos. Apo.Sol.: ARQUES GIRBAU ARTUR;ROVIRA FERRER DAVID. Apo.Manc.: LORENTE TARDIOMARIA DEL CARMEN;GARCIA MORENO LUCIA;CABRERA SAUQUILLO JAVIER. Datos registrales. T 4389 , F 32, S 8, H Z 2145,I/A 32 ( 5.01.21).

04 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARQUES GIRBAU ARTUR;DOLZ ANDRES JAVIER;POLVERINO MAURIZIO. Presidente: ARQUESGIRBAU ARTUR. Vicepresid.: POLVERINO MAURIZIO. Con.Delegado: ARQUES GIRBAU ARTUR. Consejero: TOBIAS BAZANEDUARDO;MANGUES SANZ JAIME. SecreNoConsj: ALMIRALL MATEU JOSE ORIOL. Nombramientos. Adm. Mancom.: ARQUESGIRBAU ARTUR;ROVIRA FERRER DAVID. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 4389 , F 31, S 8, H Z 2145, I/A 30 (24.12.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOLZ ANDRES JAVIER;TOBIAS BAZAN EDUARDO. Datos registrales. T 4389 , F 32, S 8, H Z2145, I/A 31 (24.12.20).

27 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MORENO LUCIA. Datos registrales. T 4389 , F 30, S 8, H Z 2145, I/A 29 (21.08.20).

20 de Abril de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIRAS MASSAGER IGNACIO. Nombramientos. Consejero: MANGUES SANZ JAIME. Datosregistrales. T 4389 , F 29, S 8, H Z 2145, I/A 28 ( 8.04.20).

11 de Marzo de 2020
Revocaciones. Auditor: NIETO AVELLANED JAVIER. Aud.Supl.: GRACIA HERREIZ FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Auditor:UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL. Datos registrales. T 4389 , F 29, S 8, H Z 2145, I/A 27 ( 4.03.20).

07 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIRAS MASSAGER IGNACIO. Datos registrales. T 4389 , F 29, S 8, H Z 2145, I/A 26 (31.01.20).

23 de Enero de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: LORENTE TARDIO MARIA DEL CARMEN;ROVIRA FERRER DAVID. Datos registrales. T 4389 , F28, S 8, H Z 2145, I/A 25 (16.01.20).

22 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SARI脩ENA COSTA JESUS. Nombramientos. Consejero: TOBIAS BAZAN EDUARDO. Datosregistrales. T 4389 , F 26, S 8, H Z 2145, I/A 23 (15.10.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SARI脩ENA COSTA JESUS;RUIZ SANCHO ANGELES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOBIASBAZAN EDUARDO. Datos registrales. T 4389 , F 27, S 8, H Z 2145, I/A 24 (15.10.19).

06 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ SANCHO ANGELES. Datos registrales. T 4389 , F 26, S 8, H Z 2145, I/A 22 (30.07.19).

28 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARQUES GIRBAU JAUME FRANCESC. Nombramientos. Consejero: RUIZ SANCHO ANGELES.Datos registrales. T 4376 , F 192, S 8, H Z 2145, I/A 20 (21.02.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: LORENTE TARDIO MARIA DEL CARMEN;RUIZ SANCHO ANGELES. Datos registrales. T 4389 , F26, S 8, H Z 2145, I/A 21 (21.02.19).

16 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SARI脩ENA COSTA JESUS;DOLZ ANDRES JAVIER;ARQUES GIRBAU ARTUR;MIRAS MASSAGERIGNACIO;RUIZ SANCHO ANGELES;POLVERINO MAURIZIO. Datos registrales. T 4376 , F 191, S 8, H Z 2145, I/A 19 ( 9.01.19).

04 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SARI脩ENA COSTA JESUS;DOLZ ANDRES JAVIER BLAS. Nombramientos. Consejero: ARQUESGIRBAU ARTUR;SARI脩ENA COSTA JESUS;DOLZ ANDRES JAVIER;ARQUES GIRBAU JAUME FRANCESC;MIRAS MASSAGERIGNACIO;POLVERINO MAURIZIO. Presidente: ARQUES GIRBAU ARTUR. Vicepresid.: POLVERINO MAURIZIO. SecreNoConsj:ALMIRALL MATEU JOSE ORIOL. Con.Delegado: ARQUES GIRBAU ARTUR. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1926 , F 202, S 8, H Z 2145, I/A 16(26.12.18).

Otros conceptos: APROBAR UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTTUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 1926 , F203, S 8, H Z 2145, I/A 18 (26.12.18).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CATERING ARCASA. Datos registrales. T 1926 , F 203, S 8, H Z 2145, I/A 17(26.12.18).

01 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: NIETO AVELLANED JAVIER. Aud.Supl.: GRACIA HERREIZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1926 ,F 202, S 8, H Z 2145, I/A 15 (21.07.17).

24 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: NIETO AVELLANED JAVIER. Aud.Supl.: GRACIA HERREIZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1926 ,F 202, S 8, H Z 2145, I/A 14 (17.12.14).

23 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: NIETO AVELLANED JAVIER. Aud.Supl.: GRACIA HERREIZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1926 ,F 202, S 8, H Z 2145, I/A 13 (12.01.12).

02 de Marzo de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.582,28 Euros. Resultante Suscrito: 99.056,82 Euros. Datos registrales. T 1926 , F 202, S 8, H Z2145, I/A 12 (19.02.10).

18 de Febrero de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 45.237,27 Euros. Resultante Suscrito: 90.474,54 Euros. Datos registrales. T 1926 , F 201,S 8, H Z 2145, I/A 11 ( 8.02.10).

27 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: BLANCO CORTINA JESUS. Con.Delegado: BLANCO CORTINA JESUS. Vicepresid.: DOLZANDRES JAVIER BLAS. Con.Delegado: DOLZ ANDRES JAVIER BLAS. Secretario: SARI脩ENA COSTA JESUS. Con.Delegado:SARI脩ENA COSTA JESUS. Nombramientos. Adm. Solid.: SARI脩ENA COSTA JESUS;DOLZ ANDRES JAVIER BLAS.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 1926 , F 201, S 8, H Z 2145, I/A 10 (18.01.10).

21 de Diciembre de 2009
Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO ROYO 14 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 1926 , F 201, S 8, H Z 2145, I/A 9(10.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n