Buscador CIF Logo

Actos BORME Comercial Gestora Correduria De Seguros Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Comercial Gestora Correduria De Seguros Sa

Actos BORME Comercial Gestora Correduria De Seguros Sa - A08077521

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Comercial Gestora Correduria De Seguros Sa con CIF A08077521

馃敊 Perfil de Comercial Gestora Correduria De Seguros Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Comercial Gestora Correduria De Seguros Sa

08 de Agosto de 2019
Nombramientos. ADM.UNICO: GALCERAN HOMET CARLOS ALEJANDRO. Datos registrales. T 45644 , F 1, S 8, H B 66914, I/A69 (31.07.19).

21 de Marzo de 2017
Modificaciones estatutarias. ARTICULO VIGESIMO: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.Datos registrales. T 45644 , F 1, S 8, H B 66914, I/A 68 ( 9.03.17).

02 de Diciembre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: COMELLAS ARDERIU JAIME. Datos registrales. T 42713 , F 40, S 8, H B 66914, I/A 67(24.11.16).

28 de Noviembre de 2016
Revocaciones. APODERADO: ESCRICHE BORT JORDI. Datos registrales. T 42713 , F 40, S 8, H B 66914, I/A 66 (18.11.16).

23 de Agosto de 2016
Revocaciones. APODERADO: AGUDO ALCARAZ ANTONIO;GARCIA FERNANDEZ JUAN IGNACIO;JARQUE COLLADODAVID;BENITEZ GALLARDO ADOLFO;MARTIN GARCIA SALVADOR;ESCRICHE BORT JORDI. Datos registrales. T 42713 , F 40,S 8, H B 66914, I/A 65 (12.08.16).

09 de Junio de 2016
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 346/2015, AUTOFIRME DE FECHA 25/04/2016, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DELA SOCIEDAD. Datos registrales. T 42713 , F 39, S 8, H B 66914, I/A 64 ( 3.06.16).

25 de Mayo de 2016
Revocaciones. ADM.CONCURS.: ADDVANTE FORENSE CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: FAURA LLUIS ENRIQUE. Otrosconceptos: JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 346/2015, SENTENCIA232/2013, FIRME, DE FECHA 24/11/2015, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO RECAIDO EN DICHO PROCEDIMIENTO.Datos registrales. T 42713 , F 38, S 8, H B 66914, I/A 63 (18.05.16).

27 de Octubre de 2015
Nombramientos. ADM.CONCURS.: ADDVANTE CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: FAURA LLUIS ENRIQUE. Otrosconceptos: JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 346/2015,AUTO FIRME DE FECHA 22/04/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T42713 , F 37, S 8, H B 66914, I/A 62 (20.10.15).

12 de Noviembre de 2014
Revocaciones. APODERADO: ALMANSA INSA ANTONIO. Datos registrales. T 42713 , F 36, S 8, H B 66914, I/A 61 ( 4.11.14).

12 de Agosto de 2014
Nombramientos. ADM.UNICO: GALCERAN HOMET CARLOS ALEJANDRO. Datos registrales. T 42713 , F 36, S 8, H B 66914, I/A60 ( 1.08.14).

27 de Junio de 2012
Otros conceptos: DECLARACION DE PERDIDA DE LA SITUACION DE UNIPERSONALIDAD. Datos registrales. T 42713 , F 36, S8, H B 66914, I/A 59 (18.06.12).

10 de Abril de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 126.546,56 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:960.000,00 Euros. Desembolsado: 960.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 960.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 960.000,00Euros. Otros conceptos: DECLARACION DEL CARACATER DE UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:"CARLOSALEJANDRO GALCERAN HOMET". Datos registrales. T 42713 , F 34, S 8, H B 66914, I/A 58 (27.03.12).

05 de Julio de 2011
Otros conceptos: CONSTANCIA DE LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD: "WWW.COGESA.COM". Datos registrales. T 42713 , F31, S 8, H B 66914, I/A 57 (22.06.11).

04 de Mayo de 2011
Revocaciones. APODERADO: AGUDO ALCARAZ ANTONIO. Datos registrales. T 33593 , F 110, S 8, H B 66914, I/A 56 (20.04.11).

15 de Febrero de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VELASCO GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 33593 , F 110, S 8, H B 66914, I/A 55 (2.02.11).

20 de Julio de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROBRE脩O CANALETA ANTONIO. Datos registrales. T 33593 , F 110, S 8, H B 66914, I/A 54 (8.07.10).

29 de Junio de 2010
Revocaciones. APODERADO: GALCERAN HOMET VICTOR JORGE. CONSEJERO: GALCERAN HOMET CARLOS. PRESIDENTE:GALCERAN HOMET CARLOS. CONSEJERO: GALCERAN HOMET VICTOR JORGE. VICEPRESIDEN: GALCERAN HOMETVICTOR JORGE. CONS. DELEG.: GALCERAN HOMET VICTOR JORGE. CONSEJERO: AGUDO ALCARAZ ANTONIO.SECRETARIO: AGUDO ALCARAZ ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: GALCERAN HOMET CARLOS ALEJANDRO.Modificaciones estatutarias. ARTS.5,6,10,15,19,21,22,23 Y 27 Y ART.20 (SIN CONTENIDO).- CAMBIO DE REGIMENADMINISTRATIVO. Otros conceptos: No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Art. 378.5 delReglamento del Registro Mercantil).EJERCICIO DE LA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA ELCONSEJERO,VICTOR GALCERAN HOMET. Datos registrales. T 33593 , F 108, S 8, H B 66914, I/A 53 (16.06.10).

14 de Agosto de 2009
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 33593 , F 108, S 8, H B 66914, I/A 52 (4.08.09).

17 de Julio de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 33593 , F 108, S 8, H B 66914, I/A 51 (7.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n