Buscador CIF Logo

Actos BORME Comercial Grupo Anaya Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Comercial Grupo Anaya Sa

Actos BORME Comercial Grupo Anaya Sa - A79408720

Tenemos registrados 64 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Comercial Grupo Anaya Sa con CIF A79408720

馃敊 Perfil de Comercial Grupo Anaya Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Comercial Grupo Anaya Sa

14 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAKHOUCHE FABRICE. Vicepresid.: BAKHOUCHE FABRICE. Cons.Del.Sol: BAKHOUCHEFABRICE. Nombramientos. Consejero: HELENE HAUWEL PAULINE CHRISTINE. Vicepresid.: HELENE HAUWEL PAULINECHRISTINE. Datos registrales. T 43378 , F 202, S 8, H M 2642, I/A 152 ( 6.11.23).

14 de Junio de 2023
Ampliacion del objeto social. d) Los actividades, negocios y servicios de formaci贸n, orientaci贸n educativa, ense帽anza y/o educaci贸nde toda 铆ndole; la explotaci贸n y gesti贸n de todo tipo de centros e instituciones de ense帽anza, educaci贸n y todo elfo en todos losniveles, sujetas o cualquier regulaci贸n, presencial y/o a distancia,. Datos registrales. T 43378 , F 201, S 8, H M 2642, I/A 150 (7.06.23).

01 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO PLAZUELO RUBEN. Datos registrales. T 43378 , F 201, S 8, H M 2642, I/A 149 (25.01.23).

11 de Enero de 2023
Cambio de domicilio social. C/ VALENTIN BEATO 21 (MADRID). Datos registrales. T 43378 , F 200, S 8, H M 2642, I/A 148 (3.01.23).

30 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43378 , F 200, S 8, H M 2642, I/A 147 (23.11.22).

13 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN IBARRA JORGE. Datos registrales. T 29627 , F 208, S 8, H M 2642, I/A 146 ( 6.05.22).

11 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ RUIZ FRANCISCO. Datos registrales. T 29627 , F 208, S 8, H M 2642, I/A 145 ( 4.04.22).

25 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: ALFAYA HURTADO ISABEL;ALFAYA HURTADO ISABEL;ALFAYA HURTADO ISABEL. Datosregistrales. T 29627 , F 207, S 8, H M 2642, I/A 143 (18.11.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUITIAN GONZALEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 29627 , F 207, S 8, H M 2642, I/A 144(18.11.21).

24 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: BLANCO RIVERA MARIA JOSE. Datos registrales. T 29627 , F 206, S 8, H M 2642, I/A 142(17.09.21).

03 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: CONTRERAS NODAL ANSELMO;CONTRERAS NODAL ANSELMO. Datos registrales. T 29627 , F206, S 8, H M 2642, I/A 140 (27.07.21).

Revocaciones. Apoderado: TREVI脩O MARCANO MANUEL. Datos registrales. T 29627 , F 206, S 8, H M 2642, I/A 141 (27.07.21).

28 de Julio de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 206, S 8, H M 2642, I/A 139 (21.07.21).

09 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOURRY ARNAUD;MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA;CIRES MARTINEZ PABLO.Presidente: NOURRY ARNAUD. Cons.Del.Sol: NOURRY ARNAUD;MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA;CIRES MARTINEZ PABLO;BAKHOUCHE FABRICE. Presidente: MARTINEZGUTIERREZ MARTA CANDIDA. Vicepresid.: BAKHOUCHE FABRICE. Cons.Del.Sol: MARTINEZ GUTIERREZ MARTACANDIDA;BAKHOUCHE FABRICE. Reelecciones. SecreNoConsj: GARCIA ROMAN AGUSTIN JOSE. Datos registrales. T 29627 ,F 205, S 8, H M 2642, I/A 138 ( 2.07.21).

11 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: REMACHA ROIG MARIA DE LOS ANGELES;GONZALEZ CONDE CAMILO. Datos registrales. T 29627, F 204, S 8, H M 2642, I/A 136 ( 2.12.20).

Nombramientos. Apoderado: PINO RODRIGUEZ DARIO. Datos registrales. T 29627 , F 204, S 8, H M 2642, I/A 137 ( 2.12.20).

17 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERA CAMPOS OTILIO. Datos registrales. T 29627 , F 204, S 8, H M 2642, I/A 135(10.11.20).

29 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: CAZA脩A AGUILAR JAVIER JESUS. Datos registrales. T 29627 , F 200, S 8, H M 2642, I/A 133(22.10.20).

Nombramientos. Apoderado: REMACHA ROIG MARIA ANGELES. Datos registrales. T 29627 , F 202, S 8, H M 2642, I/A 134(22.10.20).

11 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 200, S 8, H M 2642, I/A 132 ( 3.08.20).

07 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apoderado: HUETE MU脩OZ MARIO. Datos registrales. T 29627 , F 200, S 8, H M 2642, I/A 131 (31.07.20).

05 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: CIRES MARTINEZ PABLO. Datos registrales. T 29627 , F 197, S 8, H M 2642, I/A 129 (29.07.20).

Nombramientos. Apoderado: PINAR VELIX RAIMUNDO. Datos registrales. T 29627 , F 199, S 8, H M 2642, I/A 130 (29.07.20).

28 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOURRY ARNAUD;MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA;HUETE MU脩OZ MARIO. Presidente:NOURRY ARNAUD. Cons.Del.Sol: NOURRY ARNAUD. Co.De.Ma.So: MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA. Nombramientos.Consejero: NOURRY ARNAUD;MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA;CIRES MARTINEZ PABLO. Presidente: NOURRYARNAUD. Cons.Del.Sol: NOURRY ARNAUD;MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA. Reelecciones. SecreNoConsj: GARCIAROMAN AGUSTIN JOSE. Datos registrales. T 29627 , F 196, S 8, H M 2642, I/A 128 (21.07.20).

03 de Julio de 2020
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ GARCIA JESUS. Datos registrales. T 29627 , F 196, S 8, H M 2642, I/A 127 (26.06.20).

16 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ROMAN AGUSTIN JOSE. Datos registrales. T 29627 , F 195, S 8, H M 2642, I/A 126 (9.06.20).

21 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ GARCIA JESUS. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA ROMAN AGUSTINJOSE. Datos registrales. T 29627 , F 195, S 8, H M 2642, I/A 125 (13.05.20).

31 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Consejero: HUETE MU脩OZ MARIO;GOMEZ RODRIGUEZJOSE MANUEL. Cons.Del.Sol: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Consejero: MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA.Con.Delegado: MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA. Nombramientos. Consejero: NOURRY ARNAUD;MARTINEZGUTIERREZ MARTA CANDIDA;HUETE MU脩OZ MARIO. Presidente: NOURRY ARNAUD. Cons.Del.Sol: NOURRY ARNAUD.Co.De.Ma.So: MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA. Reelecciones. SecreNoConsj: SANCHEZ GARCIA JESUS. Datosregistrales. T 29627 , F 194, S 8, H M 2642, I/A 124 (24.01.20).

12 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 194, S 8, H M 2642, I/A 123 ( 5.09.19).

07 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ GARCIA JESUS. SecreNoConsj: SANCHEZ GARCIA JESUS. Nombramientos.SecreNoConsj: SANCHEZ GARCIA JESUS. Consejero: MARTINEZ GUTIERREZ MARTA CANDIDA. Con.Delegado: MARTINEZ

12 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: RAMOS VALERA ALFONSO. Datos registrales. T 29627 , F 193, S 8, H M 2642, I/A 121 ( 5.03.19).

04 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 193, S 8, H M 2642, I/A 120 (27.08.18).

18 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 193, S 8, H M 2642, I/A 119 (10.08.17).

26 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: MENDEZ ARROYO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 29627 , F 192, S 8, H M 2642, I/A 118(18.04.17).

02 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: PRIOR BALIBREA FRANCISCO. Datos registrales. T 29627 , F 192, S 8, H M 2642, I/A 117 (23.12.16).

30 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PRIOR BALIBREA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ GARCIA JESUS. Datosregistrales. T 29627 , F 192, S 8, H M 2642, I/A 116 (21.12.16).

05 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: AMORES RAMOS MARIO. Datos registrales. T 29627 , F 191, S 8, H M 2642, I/A 115 (23.11.16).

09 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 191, S 8, H M 2642, I/A 114 ( 1.08.16).

01 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 191, S 8, H M 2642, I/A 113 (20.08.15).

27 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Presidente: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL.Consejero: SANCHEZ GARCIA JESUS. Secretario: SANCHEZ GARCIA JESUS. Consejero: NOURRY ARNAUD;HUETE MU脩OZMARIO;PRIOR BALIBREA FRANCISCO. Con.Delegado: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Presidente:GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Consejero: HUETE MU脩OZ MARIO;PRIOR BALIBREA FRANCISCO;GOMEZ RODRIGUEZJOSE MANUEL. SecreNoConsj: SANCHEZ GARCIA JESUS. Cons.Del.Sol: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Modificacionesestatutarias. 22.Consejo de Administraci贸n.. Datos registrales. T 29627 , F 190, S 8, H M 2642, I/A 112 (17.07.15).

29 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 189, S 8, H M 2642, I/A 111 (20.08.14).

30 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ ROCH CARLOTA SOFIA. Datos registrales. T 29627 , F 189, S 8, H M 2642, I/A 110(23.06.14).

23 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ ROCH CARLA. Datos registrales. T 29627 , F 188, S 8, H M 2642, I/A 109 (12.06.14).

19 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ ROCH CARLA. Datos registrales. T 29627 , F 188, S 8, H M 2642, I/A 108 ( 9.05.14).

07 de Abril de 2014
Revocaciones. Apoderado: CERREDA DOPAZO EDUARDO. Datos registrales. T 29627 , F 188, S 8, H M 2642, I/A 106 (31.03.14).

Revocaciones. Apoderado: MARTIN VAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 29627 , F 188, S 8, H M 2642, I/A 107 (31.03.14).

24 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 187, S 8, H M 2642, I/A 105 (17.09.13).

09 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL;NOURRY ARNAUD;WASTIAUX MARIE CLAIRE;SANCHEZGARCIA JESUS. Presidente: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Secretario: SANCHEZ GARCIA JESUS. Con.Delegado: GOMEZRODRIGUEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Presidente: GOMEZRODRIGUEZ JOSE MANUEL. Consejero: SANCHEZ GARCIA JESUS. Secretario: SANCHEZ GARCIA JESUS. Consejero: NOURRYARNAUD;HUETE MU脩OZ MARIO;PRIOR BALIBREA FRANCISCO. Con.Delegado: GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL.Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los Art铆culos 18潞, 20潞, 21潞 y 25潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 29627, F 185, S 8, H M 2642, I/A 104 (28.09.12).

27 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29627 , F 185, S 8, H M 2642, I/A 103 (17.09.12).

30 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apoderado: CERREDA DOPAZO EDUARDO;GONZALEZ CONDE CAMILO;ONTIVEROS GONZALEZ FEDERICO.Datos registrales. T 29627 , F 185, S 8, H M 2642, I/A 102 (17.05.12).

09 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CONDE CAMILO. Datos registrales. T 14565 , F 196, S 8, H M 2642, I/A 99 (26.03.12).

Nombramientos. Apoderado: ONTIVEROS GONZALEZ FEDERICO. Datos registrales. T 14565 , F 196, S 8, H M 2642, I/A 100(26.03.12).

Nombramientos. Apoderado: CERREDA DOPAZO EDUARDO. Datos registrales. T 29627 , F 185, S 8, H M 2642, I/A 101(26.03.12).

23 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 14565 , F 195, S 8, H M 2642, I/A 98 (13.12.11).

19 de Octubre de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EDICIONES TORMES SA. Datos registrales. T 14565 , F 191, S 8, H M 2642, I/A97 ( 7.10.11).

12 de Julio de 2011
Otros conceptos: DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA COMPA脩IA , SIENDO LA SOCIEDAD QUE EN SU DIASERA LA ABSORBIDA , LA DENOMINADA "EDICIONES TORMES SA " .- Datos registrales. T 134 , F 110, S 8, H M 2642, I/A 1M(30.06.11).

08 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: REMACHA ROIG MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 14565 , F 190, S 8, H M 2642, I/A94 (28.06.11).

Nombramientos. Apoderado: RAMOS VALERA ALFONSO. Datos registrales. T 14565 , F 190, S 8, H M 2642, I/A 95 (28.06.11).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ RUIZ FRANCISCO. Datos registrales. T 14565 , F 191, S 8, H M 2642, I/A 96 (28.06.11).

15 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTIN VAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 14565 , F 189, S 8, H M 2642, I/A 93 ( 3.02.11).

27 de Enero de 2011
Revocaciones. Apoderado: CASILLAS GONZALEZ CRISTIAN;CASILLAS GONZALEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 14565 , F189, S 8, H M 2642, I/A 92 (17.01.11).

23 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 14565 , F 189, S 8, H M 2642, I/A 91 ( 9.12.10).

29 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: ALFAYA HURTADO ISABEL. Datos registrales. T 14565 , F 188, S 8, H M 2642, I/A 90 (19.10.10).

26 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 14565 , F 188, S 8, H M 2642, I/A 89 (16.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n