Actos BORME de Comercial Pecuaria Segoviana Sl
23 de Enero de 2023Nombramientos. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 318 , F 181, S 8, H SG 430, I/A 57 (13.01.23).
26 de Enero de 2022Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: AGROPECUARIA ENTREPINOS SL. Datos registrales. T 318 , F 176, S8, H SG 430, I/A 56 (19.01.22).
08 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GALACHE DIEZ JOSE CARLOS;FRANCISCO DE ASIS SAN FRUTOS PRIETO;EVA GONZALEZBAUTISTA;ANA MARIA ALARCON MARTINEZ;JAVIER GALLEGO BRIZUELA;ALVARO MOLINER GUTIERREZ;MARIA CANDELASGONZALEZ BERMEJO;JOSE ANTONIO ARIAS PINILLOS;JORGE OLMOS GILARRANZ;DANIEL ARIAS OLMOS. Datos registrales.T 318 , F 176, S 8, H SG 430, I/A 55 ( 1.06.21).
15 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JOMAN MU脩OZ SL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDADLIMITADA. Datos registrales. T 318 , F 171, S 8, H SG 430, I/A 54 ( 7.04.21).
28 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MARINA MU脩OZ PASCUAL. Datos registrales. T 292 , F 10, S 8, H SG 430, I/A 53 (17.12.20).
24 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 292 , F 10, S 8, H SG 430, I/A 52 (16.12.20).
23 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GALACHE DIEZ JOSE CARLOS;FRANCISCO DE ASIS SAN FRUTOS PRIETO;EVA GONZALEZBAUTISTA;ANA MARIA ALARCON MARTINEZ;JAVIER GALLEGO BRIZUELA;ALVARO MOLINER GUTIERREZ;MARIA CANDELASGONZALEZ BERMEJO;JOSE ANTONIO ARIAS PINILLOS;JORGE OLMOS GILARRANZ;DANIEL ARIAS OLMOS. Datos registrales.T 292 , F 9, S 8, H SG 430, I/A 51 (16.10.20).
03 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 292 , F 9, S 8, H SG 430, I/A 49 (20.01.20).
Nombramientos. Apoderado: VANESA BLAZQUEZ SAN FRUTOS. Datos registrales. T 292 , F 9, S 8, H SG 430, I/A 50 (20.01.20).
24 de Julio de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 292, F 7, S 8, H SG 430, I/A 47 (17.07.19).
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: HOLA FOOD SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 292 , F 7, S 8,H SG 430, I/A 48 (17.07.19).
30 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: CARLOS DEL RIO MU脩OZ. Datos registrales. T 292 , F 7, S 8, H SG 430, I/A 46 (23.05.19).
12 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOMAN MU脩OZ SL;MU脩OZ LLORENTE PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: JOMAN MU脩OZSL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T292 , F 6, S 8, H SG 430, I/A 45 ( 5.04.18).
27 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MU脩OZ LLORENTE FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: JOMAN MU脩OZ SL.Datos registrales. T 292 , F 6, S 8, H SG 430, I/A 44 (20.07.17).
06 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Auditor: CERVANTES AUDITORES SL;CERVANTES AUDITORES SL;CERVANTES AUDITORESSL;CERVANTES AUDITORES SL. Datos registrales. T 292 , F 6, S 8, H SG 430, I/A 42 (24.01.17).
Nombramientos. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 292 , F 6, S 8, H SG 430, I/A 43 (24.01.17).
23 de Octubre de 2015Nombramientos. Auditor: CERVANTES AUDITORES SL. Datos registrales. T 162 , F 199, S 8, H SG 430, I/A 41 (14.10.15).
15 de Enero de 2015Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2潞 Y 29潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. 1.Tratamiento, molturaci贸n y transformaci贸n de toda clase de cereales y productos alimenticios, propios o ajenos, individualmente odentro de un proceso de fabricaci贸n, para la obtenci贸n con o sin comercializaci贸n de harinas, pur茅s, s茅molas, panificables, alimentosdel ganado, piensos simples o com. Datos registrales. T 162 , F 199, S 8, H SG 430, I/A 40 ( 7.01.15).
05 de Mayo de 2014Ampliacion del objeto social. La instalaci贸n, administraci贸n, explotaci贸n, coordinaci贸n y gesti贸n de negocios de hosteler铆a,fundamentalmente bares, cafeter铆as, cibercaf茅s, asadores, sidrer铆as, restaurantes, fondas, pensiones, hoteles de todas las categor铆as yen general todas las actividades propias de la rama de hosteler铆a y r. Datos registrales. T 162 , F 199, S 8, H SG 430, I/A 39(21.04.14).
02 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: FRUTOS POSTIGO PEDRO;FRUTOS POSTIGO PEDRO. Apo.Sol.: MU脩OZ LLORENTE FRANCISCOJOSE. Apoderado: MU脩OZ LLORENTE FRANCISCO JOSE;ALBARRAN SANZ, MARIA PE脩A;MARIA DE FRUTOS SANZ;JOSEMIGUEL MU脩OZ HERRERO;DE FRUTOS SANZ, JUAN. Datos registrales. T 162 , F 198, S 8, H SG 430, I/A 38 (18.03.13).
11 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: MU脩OZ HERRERO, ANA MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ GALINDO, ANA MARIA. Datosregistrales. T 162 , F 198, S 8, H SG 430, I/A 37 (30.01.13).
12 de Diciembre de 2012Nombramientos. Auditor: CERVANTES AUDITORES SL. Datos registrales. T 162 , F 198, S 8, H SG 430, I/A 36 ( 4.12.12).
30 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE MIGUEL MU脩OZ HERRERO;SACRISTAN DEL CASTILLO JAVIER;RUIZ PERALTANOELIA;MU脩OZ HERRERO, ANA MARIA. Datos registrales. T 162 , F 197, S 8, H SG 430, I/A 32 (22.08.12).
Nombramientos. Apoderado: RENIEBLAS MORON MARIA SAGRARIO. Datos registrales. T 162 , F 198, S 8, H SG 430, I/A 33(22.08.12).
Nombramientos. Apoderado: ACEVES ROMO JOSE LUIS. Datos registrales. T 162 , F 198, S 8, H SG 430, I/A 34 (22.08.12).
Revocaciones. Apoderado: DE FRUTOS SANZ, JUAN;JOSE MIGUEL MU脩OZ HERRERO;MARIA DE FRUTOS SANZ;MU脩OZHERRERO, ANA MARIA. Datos registrales. T 162 , F 198, S 8, H SG 430, I/A 35 (22.08.12).
19 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: JOSE MIGUEL MU脩OZ HERRERO;DE FRUTOS SANZ, JUAN;MARIA DE FRUTOS SANZ;MU脩OZHERRERO, ANA MARIA. Datos registrales. T 162 , F 197, S 8, H SG 430, I/A 31 (10.04.12).
09 de Enero de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EMBUTIDOS LOS CERROS SL. Datos registrales. T 162 , F 195, S 8, H SG 430,I/A 30 (28.12.11).