Actos BORME de Componentes De Peluqueria Sl
02 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL. Nombramientos. Liquidador: DE LA TORRE MARTINEZANGEL. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 1523 , F 188, S 8, H TO 23436, I/A 14 (26.01.22).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Adm. Unico: DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 1523 , F 188, S 8, H TO 23436, I/A 13 (30.11.20).
15 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO;RUIZ GARCIA JOSE-ALBERTO;CONTRERAS CASTA脩EDA JUAN-JOSE. Presidente: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO. Vicepresid.: RUIZ GARCIA JOSE-ALBERTO. Secretario: CONTRERASCASTA脩EDA JUAN-JOSE. Datos registrales. T 1523 , F 188, S 8, H TO 23436, I/A 12 ( 6.10.20).
29 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: RUIZ GARCIA JOSE-ALBERTO. Nombramientos. Vicepresid.: RUIZ GARCIA JOSE-ALBERTO.Reelecciones. Consejero: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO;RUIZ GARCIA JOSE-ALBERTO. Presidente: ORTIZ SANCHEZFULGENCIO. Datos registrales. T 1523 , F 187, S 8, H TO 23436, I/A 10 (21.07.14).
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO. Datos registrales. T 1523 , F 188, S 8, H TO 23436, I/A 11(21.07.14).
24 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ JIMENEZ JOSE JAVIER. Secretario: ALVAREZ JIMENEZ JOSE JAVIER. Con.Delegado:ALVAREZ JIMENEZ JOSE JAVIER. Nombramientos. Consejero: CONTRERAS CASTA脩EDA JUAN-JOSE. Secretario:CONTRERAS CASTA脩EDA JUAN-JOSE. Datos registrales. T 1523 , F 187, S 8, H TO 23436, I/A 9 (17.10.13).
11 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL. Con.Delegado: DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL. Consejero:DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO. Nombramientos. Presidente: ORTIZ SANCHEZFULGENCIO. Con.Delegado: ALVAREZ JIMENEZ JOSE JAVIER. Datos registrales. T 1523 , F 187, S 8, H TO 23436, I/A 8 (2.07.12).
01 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ CORDERO JUAN JOSE. Consejero: GONZALEZ CORDERO JUAN JOSE.Nombramientos. Consejero: ALVAREZ JIMENEZ JOSE JAVIER. Secretario: ALVAREZ JIMENEZ JOSE JAVIER. Reelecciones.Consejero: DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL;ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO;RUIZ GARCIA ALBERTO. Presidente: DE LA TORREMARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO. Vicesecret.: RUIZ GARCIA ALBERTO. Con.Delegado: DE LATORRE MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 1523 , F 187, S 8, H TO 23436, I/A 7 (20.02.12).
04 de Julio de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.036,00 Euros. Resultante Suscrito: 294.504,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 51.672,00Euros. Resultante Suscrito: 346.176,00 Euros. Datos registrales. T 1307 , F 58, S 8, H TO 23436, I/A 6 (21.06.11).
28 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GARCIA JOSE LUIS. Secretario: GARCIA GARCIA JOSE LUIS. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ CORDERO JUAN JOSE. Secretario: GONZALEZ CORDERO JUAN JOSE. Reelecciones. Presidente: DELA TORRE MARTINEZ ANGEL. Con.Delegado: DE LA TORRE MARTINEZ ANGEL. Consejero: DE LA TORRE MARTINEZANGEL;ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO;RUIZ GARCIA ALBERTO. Vicepresid.: ORTIZ SANCHEZ FULGENCIO. Vicesecret.: RUIZGARCIA ALBERTO. Datos registrales. T 1307 , F 58, S 8, H TO 23436, I/A 5 (15.07.10).