Actos BORME de Conde De La Cortina Sl
14 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ANTO脩ANZAS ALVEAR MARTA. Consejero: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Presidente:GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Consejero: NARANJO MARTINEZ MARIA CARMEN. Vicepresid.: NARANJO MARTINEZMARIA CARMEN. Consejero: ANTO脩ANZAS ALVEAR FERNANDO;EIZAGUIRRE ALVEAR CARLOS;GIMENEZ ALVEAR LUIS.Con.Delegado: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Consejero: ALVEAR COLINO MARIA. Nombramientos. Adm. Mancom.:GIMENEZ ALVEAR LUIS;ANTO脩ANZAS ALVEAR FERNANDO. Otros conceptos: Modificaci贸n y refundici贸n de los EstatutosSociales. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Cambio dedenominaci贸n social. BOUCAU 10 SL. Cambio de objeto social. La adquisici贸n, rehabilitaci贸n, enajenaci贸n, construcci贸n yarrendamiento de fincas urbanas, r煤sticas, terrenos y solares, v su urbanizaci贸n y parcelaci贸n. El CNAE correspondiente a la actividadprincipal de la Sociedad es el 6810.- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Datos registrales. T 967 , F 77, S 8, HCO 3717, I/A 44 ( 3.08.23).
28 de Julio de 2022Reelecciones. Consejero: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Presidente: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Consejero:NARANJO MARTINEZ MARIA CARMEN. Vicepresid.: NARANJO MARTINEZ MARIA CARMEN. Consejero: ANTO脩ANZAS ALVEARFERNANDO;EIZAGUIRRE ALVEAR CARLOS;GIMENEZ ALVEAR LUIS. Con.Delegado: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO.Consejero: ALVEAR COLINO MARIA. SecreNoConsj: ANTO脩ANZAS ALVEAR MARTA. Datos registrales. T 967 , F 76, S 8, H CO3717, I/A 43 (21.07.22).
21 de Junio de 2021Modificaciones estatutarias. 24. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 967 , F 76, S 8, H CO3717, I/A 42 (15.06.21).
13 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ ALVEAR LUIS. Datos registrales. T 967 , F 75, S 8, H CO 3717, I/A 41 ( 5.04.21).
11 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVEAR COLINO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: ALVEAR COLINO MARIA. Datosregistrales. T 967 , F 75, S 8, H CO 3717, I/A 40 ( 3.12.20).
31 de Agosto de 2016Otros conceptos: Refundici贸n total de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 893 , F 39, S 8, H CO 3717, I/A 39 (24.08.16).
08 de Agosto de 2016Reelecciones. Consejero: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Presidente: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Consejero:NARANJO MARTINEZ MARIA CARMEN. Vicepresid.: NARANJO MARTINEZ MARIA CARMEN. Consejero: ANTO脩ANZAS ALVEARFERNANDO;EIZAGUIRRE ALVEAR CARLOS;GIMENEZ ALVEAR LUIS. Con.Delegado: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO.Consejero: ALVEAR COLINO FERNANDO. SecreNoConsj: ANTO脩ANZAS ALVEAR MARTA. Datos registrales. T 893 , F 39, S 8, HCO 3717, I/A 38 ( 1.08.16).
23 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: AGUILAR LUQUE MARIA CARMEN;CABELLO REQUENA FRANCISCO;RODRIGUEZ PANADERORAFAEL;LUCENA VELASCO BERNARDO ENRIQUE. Datos registrales. T 893 , F 39, S 8, H CO 3717, I/A 37 (13.03.15).
17 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 33. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 893 , F 38, S 8, H CO 3717, I/A35 ( 9.02.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVEAR COLINO MARIA. Nombramientos. Consejero: ALVEAR COLINO FERNANDO. Datosregistrales. T 893 , F 38, S 8, H CO 3717, I/A 36 ( 9.02.15).
10 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: EIZAGUIRRE ALVEAR SOLEDAD. Datos registrales. T 893 , F 38, S 8, H CO 3717, I/A 34 ( 2.07.14).
14 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ CHURRUCA MARIA LOURDES. Datos registrales. T 893 , F 38, S 8, H CO 3717, I/A33 ( 7.02.14).
12 de Febrero de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 213.174,70 Euros. Resultante Suscrito: 747.704,10 Euros. Modificaciones estatutarias. 24.Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 893 , F 37, S 8, H CO 3717, I/A 32 ( 5.02.13).
18 de Abril de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 306.149,40 Euros. Resultante Suscrito: 534.529,40 Euros. Datos registrales. T 893 , F 37, S 8, HCO 3717, I/A 31 ( 9.04.12).
30 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVEAR ZUBIRIA JUAN BOSCO;ANTO脩ANZAS ALVEAR MARTA. Presidente: ALVEAR ZUBIRIAJUAN BOSCO. Secretario: ANTO脩ANZAS ALVEAR MARTA. Consejero: ANTO脩ANZAS ALVEAR LUIS;ALVEAR ZUBIRIA MARIACARMEN;ALVEAR NARANJO RAUL;ALVEAR COLINO FERNANDO;GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Con.Delegado: GIMENEZALVEAR FERNANDO PIO. Vicepresid.: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Consejero: DOMINGUEZ CHURRUCA MARIALOURDES;EIZAGUIRRE ALVEAR CARLOS. Nombramientos. Consejero: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Presidente:GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO. Consejero: NARANJO MARTINEZ MARIA CARMEN. Vicepresid.: NARANJO MARTINEZMARIA CARMEN. Consejero: DOMINGUEZ CHURRUCA MARIA LOURDES;ANTO脩ANZAS ALVEAR FERNANDO;EIZAGUIRREALVEAR CARLOS;ALVEAR COLINO MARIA;GIMENEZ ALVEAR LUIS. Con.Delegado: GIMENEZ ALVEAR FERNANDO PIO.SecreNoConsj: ANTO脩ANZAS ALVEAR MARTA. Datos registrales. T 893 , F 36, S 8, H CO 3717, I/A 30 (19.01.12).
12 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVEAR COLINO MARIA. Nombramientos. Consejero: ALVEAR COLINO FERNANDO. Datosregistrales. T 893 , F 36, S 8, H CO 3717, I/A 29 ( 4.02.10).