Actos BORME de Condenet Iberica Sl
21 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GAMERO DEL CASTILLO CALLEJA NATALIA;BOWES WILLIAM ALEXANDER;MARTIN-MORENOCARNERO JUAN-MANUEL. Presidente: GAMERO DEL CASTILLO CALLEJA NATALIA. Vicepr.1: BOWES WILLIAM ALEXANDER.Vicepr.2: MARTIN-MORENO CARNERO JUAN-MANUEL. SecreNoConsj: VEGA-PENICHET LOPEZ JUAN. Disoluci贸n. Fusion.Extinci贸n. Datos registrales. T 35271 , F 35, S 8, H M 254740, I/A 21 (14.07.22).
02 de Marzo de 2022Cambio de objeto social. 1.- Comprar, vender, imprimir y publicar por cualquier medio, revistas (CNEA 5814), peri贸dicos, libros,im谩genes, fotograf铆as, obras de arte, partituras de obras musicales o canciones. As铆 como su explotaci贸n, por cualquier medio, inclusointernet o cualquier otro sistema inform谩tico o de difusi贸n.. Datos registrales. T 35271 , F 35, S 8, H M 254740, I/A 20 (23.02.22).
31 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35271 , F 34, S 8, H M 254740, I/A 19 (24.12.21).
30 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: SANJURJO ALONSO ELENA ISABEL AEMMER;SANCHEZ GUILLEN BEATRIZ;VITA DE MIGUELMARIA;DOMINGUEZ SAMPERE MARIA DE LOS REYES;VEGA-PENICHET LOPEZ JUAN. Datos registrales. T 35271 , F 31, S 8, HM 254740, I/A 18 (23.12.21).
29 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAMERO DEL CASTILLO CALLEJA NATALIA. Nombramientos. SecreNoConsj: VEGA-PENICHET LOPEZ JUAN. Consejero: GAMERO DEL CASTILLO CALLEJA NATALIA;BOWES WILLIAM ALEXANDER;MARTIN-MORENO CARNERO JUAN-MANUEL. Presidente: GAMERO DEL CASTILLO CALLEJA NATALIA. Vicepr.1: BOWES WILLIAMALEXANDER. Vicepr.2: MARTIN-MORENO CARNERO JUAN-MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 35271 , F 31, S 8, H M 254740, I/A 17 (22.12.21).
24 de Mayo de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35271 , F 31, S 8, H M 254740, I/A 16 (14.05.21).
03 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PASCUAL DEL OLMO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: GAMERO DELCASTILLO CALLEJA NATALIA. Datos registrales. T 35271 , F 30, S 8, H M 254740, I/A 15 (27.08.19).
14 de Junio de 2018Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35271 , F 30, S 8, H M 254740, I/A 14 ( 6.06.18).
01 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTIN-MORENO CARNERO JUAN-MANUEL. Datos registrales. T 15218 , F 139, S 8, H M 254740,I/A 13 (25.01.17).
31 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: TORRES-QUEVEDO LOPEZ-BOSCH CRISTINA. Datos registrales. T 15218 , F 138, S 8, H M254740, I/A 11 (24.01.17).
Nombramientos. Apoderado: AEMMER SANJURJO ALONSO ELENA ISABEL. Datos registrales. T 15218 , F 138, S 8, H M254740, I/A 12 (24.01.17).
03 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAMERO DEL CASTILLO CALLEJA NATALIA. Datos registrales. T 15218 , F 137, S 8, H M254740, I/A 10 (24.07.12).
21 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA, 9-11 (MADRID). Datos registrales. T 15218 , F 136, S 8, H M 254740,I/A 9 (10.02.12).
17 de Mayo de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Datos registrales. T15218 , F 136, S 8, H M 254740, I/A 8 ( 5.05.11).
21 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: TORRES-QUEVEDO LOPEZ-BOSCH CRISTINA. Datos registrales. T 15218 , F 135, S 8, H M254740, I/A 7 ( 9.03.11).
01 de Septiembre de 2010Modificaciones estatutarias. 22. DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL PRINCIPIO MAYORITARIO.-. Datos registrales. T15218 , F 135, S 8, H M 254740, I/A 6 (19.08.10).