Actos BORME de Confordes Sociedad Limitada
14 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: OCEJO MARIN ENRIQUE. Datos registrales. T 3085 , F 166, S 8, H Z 6272, I/A 86 ( 7.11.23).
26 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ALTOLAGUIRRE ABRIL PEDRO. Datos registrales. T 3085 , F 166, S 8, H Z 6272, I/A 85 (19.04.23).
05 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3085 , F 165, S 8, H Z 6272, I/A 84(29.12.22).
22 de Abril de 2021Cambio de domicilio social. PLAZA DE UTRILLAS 4 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3085 , F 165, S 8, H Z 6272, I/A 83(15.04.21).
03 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3085 , F 165, S 8, H Z 6272, I/A82 (26.11.19).
21 de Diciembre de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3085 , F 165, S 8, H Z 6272, I/A 80 (13.12.16).
02 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: MARZO RAMO MIGUEL. Datos registrales. T 3085 , F 164, S 8, H Z 6272, I/A 79 (24.11.16).
29 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3085 , F 164, S 8, H Z 6272, I/A 78 (19.02.16).
15 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLANS GARCIA ALVARO. Vicepresid.: SOLANS GARCIA ALVARO. Nombramientos. Consejero:GRUPOPIKOLIN SL. Datos registrales. T 3085 , F 164, S 8, H Z 6272, I/A 77 ( 6.10.14).
28 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: MONTESA SERAL JESUS. Datos registrales. T 3085 , F 164, S 8, H Z 6272, I/A 76 (20.08.14).
08 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: SERICHOL MALLOL JESUS;CONDADO SACRISTAN JOSE LUIS;MENDIZABAL JORAJURIA JOSEMARIA. Apo.Sol.: VITORIA AGREDA ANDRES JESUS. Apoderado: ADELL ALQUEZAR JOSE IGNACIO. Apo.Sol.: MONTIEL LOPEZANTONIO;MONTORIO SANJUAN PEDRO;LAINEZ HERNANDEZ MARIO. Apoderado: OCEJO MARIN ENRIQUE. Datos registrales.T 3085 , F 164, S 8, H Z 6272, I/A 75 (27.06.14).