Actos BORME de Confortpisos Sl
20 de Junio de 2023Cambio de domicilio social. CL JOAN DE LA CIERVA Num.19 (SANT JUST DESVERN). Datos registrales. T 47187 , F 72, S 8, HB 167122, I/A 26 (13.06.23).
30 de Mayo de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30.002,52 Euros. Resultante Suscrito: 3.790.661,54 Euros. Datos registrales. T 47187 , F72, S 8, H B 167122, I/A 25 (22.05.23).
25 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 35.002,94 Euros. Resultante Suscrito: 3.820.664,06 Euros. Datos registrales. T 47187 , F71, S 8, H B 167122, I/A 24 (18.08.22).
12 de Abril de 2021Revocaciones. CONSEJERO: LOZANO CRUZ JUAN. SECRETARIO: LOZANO CRUZ JUAN. CONSEJERO: LOZANO DEROSSELLO MERCEDES;LOZANO DE ROSELLO DAVID. PRESIDENTE: LOZANO DE ROSSELLO MERCEDES. CONS.DEL.SOL:
22 de Enero de 2020Revocaciones. CONSEJERO: LOZANO CRUZ FRANCISCO. PRESIDENTE: LOZANO CRUZ FRANCISCO. CONS. DELEG.:LOZANO CRUZ FRANCISCO. Nombramientos. PRESIDENTE: LOZANO DE ROSSELLO MERCEDES. CONS.DEL.SOL: LOZANODE ROSSELLO MERCEDES. Datos registrales. T 47187 , F 71, S 8, H B 167122, I/A 22 (14.01.20).
30 de Noviembre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 300.007,20 Euros. Resultante Suscrito: 3.855.667,00 Euros. Datos registrales. T 36669 ,F 150, S 8, H B 167122, I/A 21 (20.11.15).
28 de Noviembre de 2014Revocaciones. CONS.DEL.MAN: LOZANO DE ROSSELLO DAVID;LOZANO DE ROSSELLO MERCEDES. Datos registrales. T36669 , F 150, S 8, H B 167122, I/A 20 (20.11.14).
18 de Agosto de 2014Revocaciones. CONS. DELEG.: LOZANO DE ROSSELLO MERCEDES. Nombramientos. CONS. DELEG.: LOZANO CRUZFRANCISCO. CONS.DEL.MAN: LOZANO DE ROSSELLO DAVID;LOZANO DE ROSSELLO MERCEDES. Datos registrales. T36669 , F 150, S 8, H B 167122, I/A 19 ( 7.08.14).
04 de Febrero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 231.642,08 Euros. Resultante Suscrito: 4.155.674,20 Euros. Datos registrales. T 36669 ,F 149, S 8, H B 167122, I/A 18 (27.01.14).
05 de Septiembre de 2013Revocaciones. CONS.DEL.MAN: LOZANO DE ROSELLO MERCEDES;LOZANO DE ROSELLO DAVID. Nombramientos. CONS.DELEG.: LOZANO DE ROSSELLO MERCEDES. Datos registrales. T 36669 , F 149, S 8, H B 167122, I/A 17 (28.08.13).
05 de Marzo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 199.998,80 Euros. Resultante Suscrito: 4.387.316,28 Euros. Datos registrales. T 36669 ,F 148, S 8, H B 167122, I/A 16 (25.02.13).
18 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 36669 , F 148, S 8, H B 167122, I/A 15 ( 5.10.12).
13 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 350.005,40 Euros. Resultante Suscrito: 4.560.035,08 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 27.280,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.587.315,08 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9.-TRANSMISION DEPARTICIPACIONES;ARTICULO 12.-JUNTA GENERAL;ARTICULO 19.-GRATUIDAD DE LOS CARGOS DEL ORGANO DEADMINISTRACION. Datos registrales. T 36669 , F 144, S 8, H B 167122, I/A 14 (31.01.12).
28 de Febrero de 2011Revocaciones. ADMINISTR.: LOZANO CRUZ FRANCISCO. ADM.SOLIDAR.: LOZANO DE ROSELLO MERCEDES.Nombramientos. CONS.DEL.MAN: LOZANO DE ROSELLO MERCEDES. CONSEJERO: LOZANO CRUZ FRANCISCO.PRESIDENTE: LOZANO CRUZ FRANCISCO. CONSEJERO: LOZANO CRUZ JUAN. SECRETARIO: LOZANO CRUZ JUAN.CONSEJERO: LOZANO DE ROSELLO MERCEDES;LOZANO DE ROSELLO DAVID. CONS.DEL.MAN: LOZANO DE ROSELLODAVID. Modificaciones estatutarias. ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DEADMINISTRADOR. Datos registrales. T 36669 , F 143, S 8, H B 167122, I/A 13 (16.02.11).
11 de Noviembre de 2010Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LOZANO DE ROSELLO MERCEDES. Datos registrales. T 36669 , F 143, S 8, H B 167122, I/A12 (28.10.10).
04 de Marzo de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 795.000,77 Euros. Resultante Suscrito: 4.910.040,48 Euros. Datos registrales. T 36669 ,F 142, S 8, H B 167122, I/A 11 (19.02.10).
18 de Febrero de 2010Cambio de domicilio social. CL SANT ANTONI MARIA CLARET, 30-32, P.ENT, PTA.1 (ESPLUGUES DE LLOBREGAT). Datosregistrales. T 36669 , F 142, S 8, H B 167122, I/A 10 ( 8.02.10).