Actos BORME de Congresos Y Turismo De Sevilla Sociedad Anonima
20 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Presidente: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Consejero: PAEZVELEZ-BRACHO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: PAEZ VELEZ-BRACHO FRANCISCO JAVIER. Consejero: GAYA SANCHEZMARIA SONIA;DE LA ROSA BONSON JUAN;BELMONTE GOMEZ RAFAEL;RINCON CARDOSO EVELIA;AUMESQUET GUERLEMIGUEL ANGEL;GOMEZ SANCHEZ MARIA LUISA;DE LEON CARRILLO JUAN CARLOS;MORALES PI脩AL DE CASTILLARAUL;SOLA TEYSSIERE JAVIER. Con.Delegado: PAEZ VELEZ-BRACHO FRANCISCO JAVIER. Revocaciones. Apoderado:JIMENEZ RUIZ ANTONIO JESUS. Nombramientos. Consejero: BUENO NAVARRO JUAN;MORENO RAMON ANGELAMARIA;SALAS LOPEZ MINERVA;DE LA ROSA BONSON JUAN;DOMINGUEZ LABRADOR JUAN JOSE;MU脩OZ MARTINEZANTONIO;PAEZ VELEZ BRACHO FRANCISCO JAVIER;GUEVARA GARCIA JOSE LUIS DAVID;GAYA SANCHEZ SONIA;MORALESPI脩AL DE CASTILLA RAUL;MORGAZ ROSALES CAMINO. Con.Delegado: MORENO RAMON ANGELA MARIA. Gerente: CASTA脩OJUNCA ANTONIO. Apoderado: CASTA脩O JUNCA ANTONIO. Otros conceptos: CESA al gerente D. Antonio Jes煤s Jim茅nez Ruiz.-Datos registrales. T 6053 , F 214, S 8, H SE100784, I/A 27 (12.09.23).
23 de Junio de 2023Reelecciones. Apoderado: JIMENEZ RUIZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 6053 , F 213, S 8, H SE100784, I/A 25(16.06.23).
09 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Nombramientos. Con.Delegado: PAEZ VELEZ-BRACHOFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 6053 , F 213, S 8, H SE100784, I/A 24 (25.04.22).
22 de Marzo de 2022Nombramientos. Consejero: SOLA TEYSSIERE JAVIER. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado:2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.500.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 6.500.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5.- Capital social y acciones.. Datos registrales. T 5832 , F 60, S 8, H SE100784, I/A23 (10.03.22).
24 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 5832 , F 59, S 8, H SE100784, I/A 20 (16.03.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LARA MONTES ISABEL;CONFORTO SESTO GRACIELA. Nombramientos. Consejero: DE LEONCARRILLO JUAN CARLOS;MORALES PI脩AL DE CASTILLA RAUL. Modificaciones estatutarias. 10. Organos de gobierno yadministraci贸n. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. 27. Facultades y competencias del Consejo.-. Cambio de objeto social.1.- La gesti贸n de las pol铆ticas municipales de promoci贸n, fomento e informaci贸n tur铆stica de la ciudad de Sevilla, incluyendo laproyecci贸n de su imagen a nivel nacional e internacional, y a tal fin: a- La promoci贸n y el fomento del turismo en la ciudad de Sevilla,.Datos registrales. T 5832 , F 59, S 8, H SE100784, I/A 21 (16.03.21).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.500.000,00 Euros. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.500.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 5832 , F 60, S 8, H SE100784, I/A 22 (16.03.21).
24 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ RUIZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 5832 , F 57, S 8, H SE100784, I/A 17(14.04.20).
Nombramientos. Con.Delegado: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5832 , F 58, S 8, H SE100784, I/A 18(14.04.20).
Revocaciones. Apoderado: ROJAS ALCARIO JESUS. Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ RUIZ ANTONIO JESUS. Datosregistrales. T 5832 , F 58, S 8, H SE100784, I/A 19 (14.04.20).
22 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ RUIZ ANTONIO JESUS. Con.Delegado: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Consejero:MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Presidente: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Consejero: CASTRE脩O LUCAS MARIA CARMENCLARISA. Vicepresid.: CASTRE脩O LUCAS MARIA CARMEN CLARISA. Consejero: GARCIA MARTIN JOSE LUIS;GOMEZ SANCHEZMARIA LUISA;SANCHEZ CASTILLO ISMAEL;LARA MONTES ISABEL;GARCIA ROSELL CARMEN;BELMONTE GOMEZRAFAEL;RIOS MOLINA MARIA CARMEN;DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MU脩OZ MARTINEZANTONIO. Presidente: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Consejero: PAEZ VELEZBRACHO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: PAEZVELEZBRACHO FRANCISCO JAVIER. Consejero: GAYA SANCHEZ MARIA SONIA;LARA MONTES ISABEL;JIMENEZ RUIZANTONIO JESUS;DE LA ROSA BONSON JUAN;BELMONTE GOMEZ RAFAEL;RINCON CARDOSO EVELIA;AUMESQUET GUERLEMIGUEL ANGEL;CONFORTO SESTO GRACIELA;GOMEZ SANCHEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 5832 , F 57, S 8, HSE100784, I/A 16 ( 8.04.20).
12 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 2潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Cambio de objeto social. Constituye el objeto social de la sociedad la gesti贸n y explotaci贸n del Palacio de Exposiciones y Congrasos de Sevilla y a tul efecto podr谩: a) Organizar directa o indirectamente congresos, exposiciones, ferias, conciertos,representaciones tea balas y cuantas actividades complementarias puedan alb. Datos registrales. T 5832 , F 56, S 8, H SE100784,I/A 15 ( 3.04.18).
31 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: HALCON BEJARANO PIA. Nombramientos. Consejero: DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO.
23 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Nombramientos. Consejero: RIOS MOLINA MARIA CARMEN.Datos registrales. T 5832 , F 55, S 8, H SE100784, I/A 13 (11.05.17).
19 de Mayo de 2017Fe de erratas: En la inscripci贸n 4陋 por error se ceso como consejero a don Gregorio Serrano Lopez. Datos registrales. T 5832 , F51, S 8, H SE100784, I/A 4 (15.01.16).
27 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MORAGA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GARCIA ROSELL CARMEN.Datos registrales. T 5832 , F 55, S 8, H SE100784, I/A 10 (20.03.17).
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5832 , F 55, S 8, H SE100784, I/A 11 (20.03.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: BELMONTE GOMEZ RAFAEL.Datos registrales. T 5832 , F 55, S 8, H SE100784, I/A 12 (20.03.17).
10 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 5832 , F 54, S 8, H SE100784, I/A 9 (27.02.17).
21 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: IBA脩EZ ROSA SUSANA. Nombramientos. Consejero: LARA MONTES ISABEL. Datosregistrales. T 5832 , F 54, S 8, H SE100784, I/A 8 (11.04.16).
26 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ZOIDO ALVAREZ JUAN IGNACIO. Presidente: ZOIDO ALVAREZ JUAN IGNACIO. Consejero: FLEYGODOY ASUNCION;BUENO NAVARRO JUAN FRANCISCO;MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO;LOPEZ PEREZ SUSANA;AGUDO RIOSMANUEL. Con.Delegado: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Consejero: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Vicepresid.: SERRANOLOPEZ GREGORIO. Nombramientos. Consejero: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Presidente: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO.Consejero: CASTRE脩O LUCAS MARIA CARMEN CLARISA. Vicepresid.: CASTRE脩O LUCAS MARIA CARMEN CLARISA. Consejero:CASTILLO SEMPERE JOAQUIN;IBA脩EZ ROSA SUSANA;DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO;SERRANO LOPEZGREGORIO;HALCON BEJARANO PIA;GARCIA MARTIN JOSE LUIS;FERNANDEZ MORAGA FRANCISCO;GOMEZ SANCHEZMARIA LUISA;SANCHEZ CASTILLO ISMAEL. Datos registrales. T 5832 , F 51, S 8, H SE100784, I/A 3 (15.01.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Revocaciones. Apoderado: SERRANO LOPEZ GREGORIO.Datos registrales. T 5832 , F 51, S 8, H SE100784, I/A 4 (15.01.16).
Nombramientos. Apoderado: ROJAS ALCARIO JESUS. Datos registrales. T 5832 , F 52, S 8, H SE100784, I/A 5 (15.01.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTILLO SEMPERE JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ RUIZ ANTONIO JESUS.Datos registrales. T 5832 , F 53, S 8, H SE100784, I/A 6 (15.01.16).
Nombramientos. Con.Delegado: MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5832 , F 54, S 8, H SE100784, I/A 7(15.01.16).
16 de Julio de 2014Nombramientos. Con.Delegado: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Vicesecret.: AMBROSIANI FERNANDEZ ANA ROSA. Datosregistrales. T 5832 , F 50, S 8, H SE100784, I/A 2 ( 9.07.14).
26 de Marzo de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.01.14. Objeto social: a) Organizar directa o indirecta de congresos, exposiciones, ferias,conciertos, representaciones teatrales y cuantas actividades complementarias puedan albergar las instalaciones del Palacio y/o susespacios anejos y complementarios. Domicilio: PLAZA NUEVA 1 - CP 41.001 (SEVILLA). Capital suscrito: 2.000.000,00 Euros.Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO SEVILLA.Nombramientos. Consejero: ZOIDO ALVAREZ JUAN IGNACIO. Presidente: ZOIDO ALVAREZ JUAN IGNACIO. Consejero: FLEYGODOY ASUNCION;BUENO NAVARRO JUAN FRANCISCO;MU脩OZ MARTINEZ ANTONIO;LOPEZ PEREZ SUSANA;AGUDO RIOSMANUEL. SecreNoConsj: FLORES DOMINGUEZ LUIS ENRIQUE. Consejero: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Vicepresid.:SERRANO LOPEZ GREGORIO. Apoderado: SERRANO LOPEZ GREGORIO. Datos registrales. T 5832 , F 46, S 8, H SE100784, I/A1 (19.03.14).