Actos BORME de Conservacion Asfalto Y Construccion Sa
15 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 151, S 8, H MA8098, I/A 174 ( 7.11.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: PE脩A HERRERA ESTRELLA;ACEDO MIRANDA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 6087, L 4994, F152, S 8, H MA 8098, I/A 175 ( 7.11.23).
18 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: YUBERO LOPEZ FELIX JESUS. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 151, S 8, H MA 8098, I/A 173 (5.10.23).
23 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: CABALLERO CATALAN FRANCISCO. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 150, S 8, H MA 8098, I/A171 (15.05.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ VELASCO JOSE. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 150, S 8, H MA 8098, I/A 172(15.05.23).
08 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ESTESO ALARCON HERMINIO;ESTESO ALARCON HERMINIO. Datos registrales. T 6087, L 4994, F149, S 8, H MA 8098, I/A 170 (31.01.23).
13 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CATALAN MARTA. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 149, S 8, H MA 8098, I/A 169 (3.01.23).
17 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: MAIA RODRIGUEZ FRANCINES DAYHANNA. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 148, S 8, H MA8098, I/A 168 ( 6.05.22).
17 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: CAROSELLI BLANCO EDUARDO. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 148, S 8, H MA 8098, I/A 167(10.03.22).
10 de Marzo de 2022Modificaci贸n de poderes. Apoderado: FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 147, S 8, HMA 8098, I/A 166 ( 3.03.22).
16 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SA脩UDO EUGENIO. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 65, S 8, H MA 8098, I/A 154( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: GARRIDO TORRECILLAS BLAS CESAR. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 65, S 8, H MA 8098,I/A 155 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SALAVERRI MARIA JOSE. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 66, S 8, H MA 8098, I/A156 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: PARRAGA MEDINA ANDRES JESUS. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 67, S 8, H MA 8098, I/A157 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: SOTO CALVO GUILLERMO. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 68, S 8, H MA 8098, I/A 158 (2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: CRESPO SOLIS ANGEL. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 68, S 8, H MA 8098, I/A 159 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MU脩IZ RAUL. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 69, S 8, H MA 8098, I/A 160 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: MANRIQUE MORALES JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 70, S 8, H MA 8098,I/A 161 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: MERCADO PEREZ JOSE CRISTOBAL. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 70, S 8, H MA 8098, I/A162 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: TORRES RUIZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 145, S 8, H MA 8098, I/A 163 (2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ MORALES FRANCISCO RAFAEL. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 146, S 8, H MA8098, I/A 164 ( 2.12.21).
Nombramientos. Apoderado: IBA脩EZ MATA PABLO JOSE. Datos registrales. T 6087, L 4994, F 147, S 8, H MA 8098, I/A 165 (2.12.21).
05 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR BARRIONUEVO JOSE LUIS. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 64, S 8, H MA 8098, I/A153 (28.07.21).
27 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: CALLES GALVEZ CINTIA. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 64, S 8, H MA 8098, I/A 152(20.05.21).
15 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: ESTIRADO VERA JORGE. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 62, S 8, H MA 8098, I/A 150 (3.03.21).
Nombramientos. Apoderado: CABALLERO CATALAN FRANCISCO. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 63, S 8, H MA 8098, I/A151 ( 3.03.21).
24 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 62, S 8, H MA 8098, I/A 149 (11.11.20).
16 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: CRUCEYRA BETRIU MIGUEL. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 61, S 8, H MA 8098, I/A 147 (5.11.20).
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ POBRE MURILLO LUIS;SANCHEZ POBRE MURILLO LUIS. Datos registrales. T 5974, L4881, F 62, S 8, H MA 8098, I/A 148 ( 5.11.20).
06 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: VILLALBA MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 60, S 8, H MA 8098, I/A 146(28.10.20).
28 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: CALVO PALOMO YOLANDA. Datos registrales. T 5974, L 4881, F 60, S 8, H MA 8098, I/A 145(20.10.20).
26 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: DE AURORA GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 184, S 8, H MA8098, I/A 144 (14.10.20).
24 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 184, S 8, H MA 8098, I/A 143 (12.07.19).
11 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: TERCERO COCA ERNESTINA. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 184, S 8, H MA 8098, I/A 142 (3.07.19).
14 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ MOLINA JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 183, S 8, H MA 8098, I/A141 ( 6.06.19).
05 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 183, S 8, H MA 8098, I/A 140 (28.01.19).
29 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: VILLALBA MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 183, S 8, H MA 8098, I/A 139(21.01.19).
16 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ POBRE MURILLO LUIS. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 182, S 8, H MA 8098, I/A137 ( 6.11.18).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ POBRE MURILLO LUIS. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 182, S 8, H MA 8098, I/A138 ( 6.11.18).
10 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: DELGADO RAMOS ENRIQUE. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 181, S 8, H MA 8098, I/A 136 (2.10.18).
08 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: GOMEZ TRAVESI EDUARDO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 181, S 8, H MA 8098, I/A 135(30.07.18).
22 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: VILLALBA MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 180, S 8, H MA 8098, I/A 133(14.06.18).
Nombramientos. Apoderado: ROJO GONZALEZ JESUS. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 180, S 8, H MA 8098, I/A 134(14.06.18).
12 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: CALDERON FERNANDEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 179, S 8, H MA 8098,I/A 132 ( 1.06.18).
24 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: MAGAN MADINABEITIA LEYRE. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 178, S 8, H MA 8098, I/A 128(15.05.18).
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ ROMERO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 178, S 8, H MA 8098, I/A129 (15.05.18).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DONNELLY JAIME. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 179, S 8, H MA 8098, I/A 130(15.05.18).
Nombramientos. Apoderado: GAMIZ PEREZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 179, S 8, H MA 8098, I/A 131(15.05.18).
04 de Mayo de 2018Reelecciones. Adm. Unico: SANDO INFRAESTRUCTURAS SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 178, S 8, H MA 8098, I/A 127(23.04.18).
05 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 177, S 8, H MA 8098, I/A 126 (22.02.18).
19 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTOS VILLASCLARAS FRANCISCO MIGUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 177, S 8, HMA 8098, I/A 125 (10.10.17).
17 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: BELLIDO SOTO MARIA AUXILIADORA;ACEDO MIRANDA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4812,L 3720, F 177, S 8, H MA 8098, I/A 124 ( 2.08.17).
31 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ESTESO ALARCON HERMINIO;POZO POZO JUANA BELEN;SANCHEZ RETAMAL ANGELRUBEN;MEDINA DE LA CHICA MIGUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 176, S 8, H MA 8098, I/A 123 (19.07.17).
02 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GAMIZ PEREZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 175, S 8, H MA 8098, I/A 121(25.05.17).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LA CRUZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 176, S 8, H MA 8098,I/A 122 (25.05.17).
03 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: VARONA FIDALGO DIEGO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 175, S 8, H MA 8098, I/A 120(21.03.17).
21 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 175, S 8, H MA 8098, I/A 119 (13.02.17).
03 de Octubre de 2016Revocaciones. Apoderado: ESCAMEZ ABAD JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 175, S 8, H MA 8098, I/A 118(23.09.16).
11 de Febrero de 2016Ampliacion del objeto social. K) Mantenimiento y reparaci贸n de equipos e instalaciones el茅ctricas y electr贸nicas, equipos einstalaciones de fontaner铆a, conducci贸n de agua y gas, equipos e instalaciones de calefacci贸n y aire acondicionado, equipos einstalaciones de seguridad y contra incendios y equipos e instalaciones de apar. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 174, S 8, H MA8098, I/A 117 ( 2.02.16).
27 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MANZANO ESTHER. Presidente: SANCHEZ MANZANO ESTHER. Consejero:FERNANDEZ BARRON MANUEL;FLORES ALES JOSE MARIA. Vicepresid.: FERNANDEZ BARRON MANUEL. Secretario: FLORESALES JOSE MARIA. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 170, S 8, H MA 8098, I/A 103 (12.08.13).
07 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 174, S 8, H MA 8098, I/A 116 (28.12.15).
20 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: LARA SANTIAGO JOSE MANUEL;LARA SANTIAGO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4812, L3720, F 174, S 8, H MA 8098, I/A 115 (11.03.15).
27 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ ROMERO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 172, S 8, H MA 8098, I/A111 (19.02.15).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DONELLY JAIME. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 172, S 8, H MA 8098, I/A 112(19.02.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROJO GONZALEZ JESUS. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 173, S 8, H MA 8098, I/A 113(19.02.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAGAN MADINABEITIA LEYRE. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 173, S 8, H MA 8098, I/A 114(19.02.15).
09 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 172, S 8, H MA 8098, I/A 110 (26.12.14).
05 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: CALDERON FERNANDEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 172, S 8, H MA 8098,I/A 109 (23.04.14).
04 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: MEDINA DE LA CHICA MIGUEL;ESTESO ALARCON HERMINIO;SANCHEZ RETAMAL ANGEL RUBEN.Datos registrales. T 4812, L 3720, F 171, S 8, H MA 8098, I/A 107 (26.03.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ DONELLY JAIME;VILLALBA MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F171, S 8, H MA 8098, I/A 108 (26.03.14).
27 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MOLINA JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 171, S 8, H MA 8098, I/A106 (19.03.14).
27 de Diciembre de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4812, L 3720, F 170, S 8, H MA 8098, I/A 105 (18.12.13).