Actos BORME de Conservas Del Noroeste Sa
27 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Aud.C.Con.: GALLAECIA AUDITORIA ECONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 66, S 8, H PO 2856, I/A 38 (16.09.22).
12 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: CONDE IGLESIAS BERNARDO. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 65, S 8, H PO 2856, I/A 37 (4.08.22).
10 de Septiembre de 2021Reelecciones. Consejero: DONAIRE GARCIA ARANDA MANUEL;CANALES BURGUILLO ESTEBAN. Vicepresid.: ILLESCASJIMENEZ FRANCISCO. Consejero: CONDE RODRIGUEZ FELIX;LAFUENTE ALVAREZ MANUEL ALFREDO;GONZALEZ PEREZRAUL;ILLESCAS JIMENEZ FRANCISCO. Presidente: CONDE RODRIGUEZ FELIX. Consejero: VILLANUEVA FONTAN ELENA.SecreNoConsj: ESTRADA IBARS RICARDO. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 65, S 8, H PO 2856, I/A 36 ( 1.09.21).
10 de Marzo de 2021Otros conceptos: Se modifican los art铆culos n煤meros 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 de los estatutossociales, se a帽aden a los mismos los art铆culos n煤meros 28, 29, 30 y 31 y se refunden dichos estatutos en un nuevo texto. Cambio deobjeto social. La adquisici贸n, manipulaci贸n, transformaci贸n y venta de conservas de pescado y mariscos. CNAE 1022- Fabricaci贸nde conservas de pescado y mariscos. La preparaci贸n, fabricaci贸n, envasado y comercializaci贸n de toda clase de productos envasadosya sean frescos, refrigerados, congelados o en conserva. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 61, S 8, H PO 2856, I/A 35 ( 2.03.21).
08 de Septiembre de 2020Nombramientos. Aud.C.Con.: GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Reelecciones. Auditor:GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 61, S 8, H PO 2856, I/A 34(31.08.20).
02 de Diciembre de 2019Nombramientos. Presidente: CONDE RODRIGUEZ FELIX. Consejero: VILLANUEVA FONTAN ELENA. Otros conceptos: En laJunta General celebrada el d铆a 19 de junio de 2.019 se acord贸 ratificar el nombramiento de do帽a Elena Villanueva Font谩n comoconsejera, quien hab铆a sido designada por cooptaci贸n. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 61, S 8, H PO 2856, I/A 32 (21.11.19).
Reelecciones. Auditor: GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 61,S 8, H PO 2856, I/A 33 (21.11.19).
21 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLANUEVA GONZALEZ IGNACIO BENITO. Presidente: VILLANUEVA GONZALEZ IGNACIOBENITO. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 60, S 8, H PO 2856, I/A 30 (10.05.19).
23 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 60,S 8, H PO 2856, I/A 29 (13.08.18).
06 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: CONDE RODRIGUEZ FELIX. Datos registrales. T 4144, L 4144, F 60, S 8, H PO 2856, I/A 28(26.01.18).
18 de Agosto de 2016Nombramientos. SecreNoConsj: ESTRADA IBARS RICARDO. Reelecciones. Consejero: DONAIRE GARCIA ARANDAMANUEL;CANALES BURGUILLO ESTEBAN. Presidente: VILLANUEVA GONZALEZ IGNACIO BENITO. Vicepresid.: ILLESCASJIMENEZ FRANCISCO. Consejero: CONDE RODRIGUEZ FELIX;LAFUENTE ALVAREZ MANUEL ALFREDO;GONZALEZ PEREZRAUL;VILLANUEVA GONZALEZ IGNACIO BENITO;ILLESCAS JIMENEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 1059, L 1059, F 211, S8, H PO 2856, I/A 27 ( 9.08.16).
18 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Datos registrales. T 1059, L 1059, F 211,S 8, H PO 2856, I/A 26 ( 8.02.16).
22 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTEPAZO MARTINEZ OLEGARIO. Datos registrales. T 1059, L 1059, F 211, S 8, H PO 2856, I/A25 (13.05.13).
15 de Enero de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: G SOTO DIAZ AUDITORES Y CONSULTORES SL. Nombramientos.Auditor: GALLAECIA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SLP. Datos registrales. T 1059, L 1059, F 211, S 8, H PO2856, I/A 24 ( 7.01.13).
02 de Enero de 2012Reelecciones. Consejero: ANTEPAZO MARTINEZ OLEGARIO;DONAIRE GARCIA ARANDA MANUEL;CANALES BURGUILLOESTEBAN. Presidente: VILLANUEVA GONZALEZ IGNACIO BENITO. Vicepresid.: ILLESCAS JIMENEZ FRANCISCO. Consejero:CONDE RODRIGUEZ FELIX;LAFUENTE ALVAREZ MANUEL ALFREDO;GONZALEZ PEREZ RAUL. Secretario: ESTRADA IBARSRICARDO. Consejero: VILLANUEVA GONZALEZ IGNACIO BENITO;ILLESCAS JIMENEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 1059, L1059, F 210, S 8, H PO 2856, I/A 23 (21.12.11).
03 de Mayo de 2010Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: EUROGAL AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: G SOTO DIAZAUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1059, L 1059, F 210, S 8, H PO 2856, I/A 22 (20.04.10).