Actos BORME de Conservas El Cidacos Sociedad Anonima
04 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ RADA SUSANA. Datos registrales. T 795 , F 209, S 8, H LO 260, I/A 58 (26.09.23).
10 de Diciembre de 2021Nombramientos. Consejero: LANDEPRO BM SOCIEDAD LIMITADA;LB FAMILYWAVE SOCIEDAD LIMITADA. Modificacionesestatutarias. Modificado el art铆culo 30 de los Estatutos sociales. Datos registrales. T 795 , F 208, S 8, H LO 260, I/A 56 (30.11.21).
04 de Octubre de 2021Reelecciones. Consejero: LAGUNAS BAROJA LEONOR. Datos registrales. T 795 , F 208, S 8, H LO 260, I/A 55 (16.09.21).
23 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: GOMEZ SANCHEZ PATROCINIO. Datos registrales. T 795 , F 208, S 8, H LO 260, I/A 54 (16.09.21).
19 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: BAROJA EZQUERRO JOSE MARIA. Con.Delegado: BAROJA EZQUERRO JOSE MARIA. Datosregistrales. T 241 , F 26, S 8, H LO 260, I/A 14 ( 2.03.00).
03 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 795 , F 208, S 8, H LO 260, I/A 53 (22.10.20).
09 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: BAROJA EZQUERRO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ TOFERAMON;COLLANTES MOLINERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 795 , F 207, S 8, H LO 260, I/A 52 (29.05.20).
30 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 795 , F 206, S 8, H LO 260, I/A 51 (19.10.18).
09 de Julio de 2018Modificaciones estatutarias. 31. Administraci贸n y Representacion.- Articulo 31 MODIFICADO ARTICULO RETRIBUCION Y PLAZODE NOMBRAMIENTO.. Datos registrales. T 795 , F 206, S 8, H LO 260, I/A 50 (29.06.18).
25 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CUEVAS BENITO CLAUDIO. Secretario: CUEVAS BENITO CLAUDIO. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ TOFE RAMON. Secretario: MARTINEZ TOFE RAMON. Reelecciones. Consejero: BAROJA MAZOFERNANDO;LAGUNAS BAROJA CARLOS;BAROJA MAZO MARIA CONCEPCION. Presidente: BAROJA MAZO FERNANDO.Cons.Del.Sol: BAROJA MAZO FERNANDO;LAGUNAS BAROJA CARLOS. Vicepresid.: LAGUNAS BAROJA CARLOS. Datosregistrales. T 795 , F 206, S 8, H LO 260, I/A 49 (17.10.17).
27 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: LAGUNAS BAROJA LEONOR. Datos registrales. T 795 , F 205, S 8, H LO 260, I/A 48 (17.11.15).
30 de Octubre de 2015Otros conceptos: Subsanaci贸n de la concesi贸n de los Incentivos Regionales de fecha 30 de diciembre de 2013, en su apartado 2.5,en virtud de la Resoluci贸n de 15 de septiembre de 2015 del Director General de Fondos Comunitarios, don Jos茅 Mar铆a Pi帽ero Campos.Datos registrales. T 629 , F 133, S 8, H LO 260, I/A 47nm (23.10.15).
18 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BAROJA EZQUERRO MARIA DOLORES. Presidente: BAROJA EZQUERRO MARIA DOLORES.Vicepresid.: BAROJA MAZO FERNANDO. Revocaciones. Apoderado: BAROJA EZQUERRO MARIA DOLORES. Nombramientos.Consejero: LAGUNAS BAROJA LEONOR. Presidente: BAROJA MAZO FERNANDO. Cons.Del.Sol: BAROJA MAZOFERNANDO;LAGUNAS BAROJA CARLOS. Vicepresid.: LAGUNAS BAROJA CARLOS. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de lap谩gina web corporativa: www.barezp.com.es. Datos registrales. T 629 , F 132, S 8, H LO 260, I/A 47 (10.09.15).
14 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 629 , F 132, S 8, H LO 260, I/A 46 ( 6.10.14).
03 de Marzo de 2014Otros conceptos: Por Orden Ministerial de 17/12/2013 se conceden INCENTIVOS REGIONALES previstos en la Ley 50/1985, de 27de diciembre, seg煤n resulta de resoluci贸n de fecha 30 de diciembre de 2013, aceptada el 12 de febrero de 2014. Datos registrales. T629 , F 130, S 8, H LO 260, I/A 45nm (24.02.14).
05 de Noviembre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TRE SA. MASQUESALSAS SL. Datos registrales. T 629 , F 130, S 8, H LO 260, I/A45 (24.10.12).
08 de Febrero de 2012Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 629 , F 130, S 8, H LO 260, I/A 44 (30.01.12).
28 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BAROJA MAZO MARIA CONCEPCION. Nombramientos. Vicepresid.: BAROJA MAZOFERNANDO. Consejero: BAROJA MAZO MARIA CONCEPCION. Reelecciones. Consejero: BAROJA EZQUERRO MARIADOLORES;CUEVAS BENITO CLAUDIO;BAROJA MAZO FERNANDO;LAGUNAS BAROJA CARLOS. Secretario: CUEVAS BENITOCLAUDIO. Presidente: BAROJA EZQUERRO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 629 , F 130, S 8, H LO 260, I/A 43 (19.10.11).
21 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: BAROJA MAZO CONCEPCION. Datos registrales. T 629 , F 129, S 8, H LO 260, I/A 42 ( 3.12.09).
18 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BAROJA EZQUERRO JOSE MANUEL. Presidente: BAROJA EZQUERRO JOSE MANUEL.Vicepresid.: BAROJA EZQUERRO MARIA DOLORES. Nombramientos. Consejero: BAROJA MAZO CONCEPCION. Presidente:BAROJA EZQUERRO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 629 , F 129, S 8, H LO 260, I/A 41 ( 3.11.09).
22 de Julio de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 29.970,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.063.380,00 Euros. Datos registrales. T 629 , F129, S 8, H LO 260, I/A 40 (13.07.09).