Actos BORME de Consorci Del Transport Sanitari Regio Girona Sa
19 de Octubre de 2023Cambio de objeto social. La prestaci贸n de servicios de transporte sanitario, por si o a trav茅s de sus socios, y en especial: -Eltransporte terrestre colectivo de viajeros o de mercanc铆as, por ciudad, en su caso, carretera y por mediante autom贸viles, en susdistintas modalidades y en especial regulares y discrecionales, urb. Datos registrales. T 3226 , F 53, S 8, H GI 15672, I/A 39(11.10.23).
17 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PEDRO MARIA MARTINEZ FERNANDEZ. Nombramientos. Adm. Mancom.: PEDRO MARIAMARTINEZ FERNANDEZ;EDUARDO-FEDERICO VIDAL REGARD;EDGAR NOLLA SANCHEZ Modificaciones estatutarias. Seestablece modificar el sistema de administraci贸n del 贸rgano de administraci贸n y en consecuencia la redacci贸n de los art铆culos 13潞, 19潞,21潞, 22潞, 25潞 y 26潞 de los Estatutos Sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 3226 , F 52, S 8, H GI 15672, I/A 38 ( 9.08.23).
05 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: CARLOS HERRERA MARTIN. Datos registrales. T 3226 , F 51, S 8, H GI 15672, I/A 37 (25.05.23).
28 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: JAUME XICART GIRO. Datos registrales. T 3226 , F 51, S 8, H GI 15672, I/A 36 (22.11.22).
24 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: LORENZO ALVAREZ ONTIVERO;FEDERICO LLOBET YLL. Datos registrales. T 3226 , F 51, S 8, H GI15672, I/A 35 (18.10.22).
17 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Auditor: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 3226 , F 51, S 8, H GI 15672, I/A 34 (11.05.21).
21 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: JAUME XICART GIRO. Datos registrales. T 3226 , F 50, S 8, H GI 15672, I/A 33 (15.04.21).
20 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: FEDERICO LLOBET YLL;LORENZO ALVAREZ ONTIVERO;AVELINO CABALLEROFERNANDEZ;MIGUEL TORRA ROVIROLA;PEDRO MARIA MARTINEZ FERNANDEZ;PEDRO LOPEZ MOLINA. Secretario: PEDROLOPEZ MOLINA. Consejero: SILVIA SISTANE GUALDA. Presidente: FEDERICO LLOBET YLL. Miem.Com.Ej.: FEDERICO LLOBETYLL. Sec.Com.Ej.: FEDERICO LLOBET YLL. Miem.Com.Ej.: JUSTO ALARCON MERLOS. Pres.Com.Ej.: JUSTO ALARCONMERLOS. Miem.Com.Ej.: AVELINO CABALLERO FERNANDEZ. Nombramientos. Adm. Unico: PEDRO MARIA MARTINEZFERNANDEZ. Modificaciones estatutarias. 13, de los 贸rganos sociales. 19, de la asistencia a la Junta General.. 21, de laConvocatoria de la Junta General.. 24潞, del 贸rgano de administraci贸n.. 26, del nombramiento y duraci贸n del cargo de Administrador..Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T3226 , F 50, S 8, H GI 15672, I/A 32 (13.05.20).
11 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: CENTURY AUDITORES SA. Datos registrales. T 3226 , F 50, S 8, H GI 15672, I/A 31 ( 4.03.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUSTO ALARCON MERLOS;RAFAEL SISTANE PUJOL. Presidente: JUSTO ALARCON MERLOS.Secretario: FEDERICO LLOBET YLL. Nombramientos. Consejero: PEDRO LOPEZ MOLINA. Secretario: PEDRO LOPEZ MOLINA.Consejero: SILVIA SISTANE GUALDA. Presidente: FEDERICO LLOBET YLL. Datos registrales. T 2234 , F 202, S 8, H GI 15672, I/A30 ( 4.03.19).
03 de Abril de 2018Ampliacion del objeto social. o Al transporte terrestre colectivo de viajeros o de mercanc铆as, por carretera y por ciudad, en su caso,mediante autom贸viles, en sus distintas modalidades y en especial regulares y discrecionales, urbanas y especiales. El transporte podr谩realizarse con car谩cter permanente o temporal y su uso podr谩. Datos registrales. T 2234 , F 202, S 8, H GI 15672, I/A 29 (22.03.18).
21 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: JAUME XICART GIRO. Nombramientos. Consejero: PEDRO MARIA MARTINEZ FERNANDEZ.Datos registrales. T 2234 , F 202, S 8, H GI 15672, I/A 28 (14.03.16).
26 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RAFAEL HOMET DUPRA. Presidente: RAFAEL HOMET DUPRA. Consejero: RAFAEL SISTANEPUJOL;AVELINO CABALLERO FERNANDEZ;MIQUEL TORRA ROVIROLA;JAUME XICART GIRO. Miem.Com.Ej.: RAFAEL HOMETDUPRA. Consejero: FEDERICO LLOBET YLL. Secretario: FEDERICO LLOBET YLL. Consejero: ANGEL NIETO MARTINEZ.Pres.Com.Ej.: RAFAEL HOMET DUPRA. Miem.Com.Ej.: FEDERICO LLOBET YLL. Sec.Com.Ej.: FEDERICO LLOBET YLL.Miem.Com.Ej.: AVELINO CABALLERO FERNANDEZ. Revocaciones. Apo.Manc.: RAFAEL HOMET DUPRA;PEDRO MARIA
05 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: MIQUEL TORRA ROVIROLA. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: AVELINO CABALLEROFERNANDEZ. Datos registrales. T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 26 (20.02.13).
11 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: RAFAEL HOMET DUPRA;PEDRO MARIA MARTINEZ FERNANDEZ;MARCOS IGNACIO CASQUETEIRIARTE. Nombramientos. Apo.Manc.: RAFAEL HOMET DUPRA;PEDRO MARIA MARTINEZ FERNANDEZ;FEDERICO LLOBETYLL. Datos registrales. T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 25 ( 1.12.12).
13 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCOS IGNACIO CASQUETE IRIARTE. Secretario: MARCOS IGNACIO CASQUETE IRIARTE.Consejero: FERMIN CASQUETE ALVAREZ. Miem.Com.Ej.: FERMIN CASQUETE ALVAREZ. Nombramientos. Consejero:FEDERICO LLOBET YLL. Secretario: FEDERICO LLOBET YLL. Consejero: ANGEL NIETO MARTINEZ. Pres.Com.Ej.: RAFAELHOMET DUPRA. Miem.Com.Ej.: FEDERICO LLOBET YLL. Sec.Com.Ej.: FEDERICO LLOBET YLL. Cambio de domicilio social. C/BESCANO 7A - POLIGONO INDUSTRIAL DE DOMENY. (GIRONA). Datos registrales. T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 24 (2.08.12).
01 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: RAFAEL SISTANE PUJOL. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MIQUEL TORRA ROVIROLA.Datos registrales. T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 23 (23.01.12).
20 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: AVELINO CABALLERO FERNANDEZ. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: RAFAEL SISTANEPUJOL. Datos registrales. T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 22 (11.01.11).
22 de Julio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: JOSE VALENTIN ANTON. Nombramientos. Apo.Manc.: RAFAEL HOMET DUPRA;PEDRO MARIAMARTINEZ FERNANDEZ;MARCOS IGNACIO CASQUETE IRIARTE. Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: PEDRO MARIAMARTINEZ FERNANDEZ. Datos registrales. T 2216 , F 91, S 8, H GI 15672, I/A 21 (13.07.10).
15 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: JOSE VALENTIN ANTON. Vicepresid.: RAFAEL SISTANE PUJOL. Secretario: RAFAEL HOMETDUPRA. Consejero: MARTIN GARCIA GARCIA;SILVIA SISTANE GUALDA. Nombramientos. Presidente: RAFAEL HOMET DUPRA.Secretario: MARCOS IGNACIO CASQUETE IRIARTE. Consejero: RAFAEL SISTANE PUJOL;AVELINO CABALLEROFERNANDEZ;MIQUEL TORRA ROVIROLA;FERMIN CASQUETE ALVAREZ;JAUME XICART GIRO. Miem.Com.Ej.: FERMINCASQUETE ALVAREZ;RAFAEL HOMET DUPRA;AVELINO CABALLERO FERNANDEZ. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comit茅 Ejecutivo. Otros conceptos: El cargo de miembro del 贸rgano deadministraci贸n pasa a tener una duraci贸n de seis a帽os. Ampliacion del objeto social. La explotaci贸n de establecimientos o cl铆nicassanitarias, de hospitalizaci贸n y asistencia m茅dico quir煤rgica en todas sus especialidades, establecimientos asistenciales sociosanitarios, residencias geri谩tricas y residenciaspara disminuidos. Datos registrales. T 2216 , F 90, S 8, H GI 15672, I/A 20 ( 2.03.10).