Actos BORME de Consorcio Andino Sl
28 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: GARZA VILLARREAL HECTOR RUBEN. Datos registrales. T 45687 , F 15, S 8, H M 408038, I/A 17(20.12.23).
08 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: ASHMAN AMY LUCY. Datos registrales. T 22796 , F 225, S 8, H M 408038, I/A 16 ( 1.09.23).
10 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GARZA RAMIREZ LEONEL;MARCOS IGA CARLOS;GONZALEZ BARRERA ROBERTO. Apoderado:LOPEZ CERVANTES CUAUHTEMOC;ROSALES SALDA脩A FERNANDO. Apo.Sol.: SOLA IGLESIAS SUSANA;AGUAYO IZQUIERDOALMUDENA;GARCIA BOENTE DAVILA ANA;MATO RODRIGUEZ IAGO. Apoderado: MONTALVO DE MARCOS DIEGO. Datosregistrales. T 22796 , F 225, S 8, H M 408038, I/A 15 ( 3.03.23).
20 de Enero de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 12陋 el nombamiento de ASHMAN AMY LUCY como Vicesecretario no Consejero,siendo lo correcto Vicesecretario del Consejo. Datos registrales. T 22796 , F 217, S 8, H M 408038, I/A 12 (21.05.19).
02 de Octubre de 2019Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES. Ampliacion del objeto social. Comprar, vender,importar y exportar, as铆 como fabricar y maquilar toda clase de bienes o productos alimenticios o relacionados con el sector de laalimentaci贸n. Adquirir, administrar, negociar, suscribir, emitir, .gravar, vender, permutar y, en general, disponer por cualquier t铆tulo, porcuenta pro. Datos registrales. T 22796 , F 218, S 8, H M 408038, I/A 14 (25.09.19).
30 de Mayo de 2019Cambio de domicilio social. AVDA BARAJAS 24 - PLANTA 2 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 22796 , F 218, S 8, H M408038, I/A 13 (23.05.19).
28 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VARGAS GUAJARDO SALVADOR. VsecrNoConsj: ELIZONDO RIOS GUILLERMO.Revocaciones. Apo.Sol.: VARGAS GUAJARDO SALVADOR;ELIZONDO RIOS GUILLERMO. Nombramientos. SecreNoConsj:MARTINEZ VILLARREAL RODRIGO. VsecrNoConsj: ASHMAN AMY LUCY. Apoderado: MARTINEZ VILLARREAL RODRIGO;GARZAVILLARREAL HECTOR RUBEN;CAVAZOS MORALES RAUL;SANCHEZ MARTINEZ ROGELIO;TREVI脩O TORRESRODOLFO;HUERTA MORENO HOMERO. Datos registrales. T 22796 , F 217, S 8, H M 408038, I/A 12 (21.05.19).
13 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ DAVID. Cambio de domicilio social. PQUE EMPRESARIAL OMEGA A-1,SALIDA 17, EDIFICIO GA (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 22796 , F 173, S 8, H M 408038, I/A 11 ( 5.05.16).
26 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ROJAS VALDES MERCEDES. Nombramientos. Consejero: ASHMAN AMY LUCY. Datosregistrales. T 22796 , F 173, S 8, H M 408038, I/A 10 (18.08.15).
24 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: QUIROGA GARCIA JUAN ANTONIO. Nombramientos. Representan: HUERTA MORENOHOMERO. Datos registrales. T 22796 , F 172, S 8, H M 408038, I/A 8 (12.02.14).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUMA SA DE CV. Representan: HUERTA MORENO HOMERO. Revocaciones. Apo.Sol.:QUIROGA GARCIA JUAN ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: VARGAS GUAJARDO SALVADOR. VsecrNoConsj:ELIZONDO RIOS GUILLERMO. Consejero: GONZALEZ MORENO JUAN ANTONIO DE JESUS. Presidente: GONZALEZ MORENOJUAN ANTONIO DE JESUS. Consejero: HUERTA MORENO HOMERO. Vicepresid.: HUERTA MORENO HOMERO. Consejero:BURKE DANNIE LEE JR;DE ROJAS VALDES MERCEDES. Apoderado: MONTALVO DE MARCOS DIEGO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 22796 ,F 172, S 8, H M 408038, I/A 9 (12.02.14).
05 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MORENO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 22796 , F 171, S 8, H M 408038, I/A 7(28.05.13).