Buscador CIF Logo

Actos BORME Construcciones Brillas Agusti Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Construcciones Brillas Agusti Sa

Actos BORME Construcciones Brillas Agusti Sa - A28193209

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Construcciones Brillas Agusti Sa con CIF A28193209

馃敊 Perfil de Construcciones Brillas Agusti Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Construcciones Brillas Agusti Sa

15 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: GONZALEZ OLMOS JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 28324 , F 34, S 8, H M 35959, I/A 44 ( 8.03.22).

09 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO. Presidente: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO.Consejero: BRILLAS PEREZ RAFAEL MARTIN. Secretario: BRILLAS PEREZ RAFAEL MARTIN. Consejero: CALSO HUERTASCARLOS. Cons.Del.Sol: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO;BRILLAS PEREZ RAFAEL MARTIN;CALSO HUERTAS CARLOS.Nombramientos. Consejero: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO;CALSO HUERTAS CARLOS;BRILLAS PEREZ RAFAELMARTIN;AGUSTI BRILLAS RAFAEL. Presidente: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO. Secretario: BRILLAS PEREZ RAFAELMARTIN. Cons.Del.Sol: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO. Cons.Del.Man: BRILLAS PEREZ RAFAEL MARTIN;CALSOHUERTAS CARLOS;AGUSTI BRILLAS RAFAEL. Datos registrales. T 28324 , F 33, S 8, H M 35959, I/A 43 ( 2.04.19).

21 de Marzo de 2019
Nombramientos. Aud.Supl.: MARIN FERNANDEZ-MUELA RICARDO. Reelecciones. Auditor: GONZALEZ OLMOS JUANIGNACIO. Datos registrales. T 28324 , F 33, S 8, H M 35959, I/A 42 (14.03.19).

09 de Octubre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL NUMERO 28, LOCAL 5 (MADRID). Datos registrales. T 28324 , F 33, S 8, H M35959, I/A 41 ( 1.10.18).

11 de Julio de 2016
Nombramientos. Auditor: GONZALEZ OLMOS JUAN IGNACIO. Aud.Supl.: CAPA AUDITORES SL. Datos registrales. T 28324 , F32, S 8, H M 35959, I/A 40 (30.06.16).

24 de Agosto de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.480,00 Euros. Resultante Suscrito: 267.120,00 Euros. Datos registrales. T 28324 , F 30,S 8, H M 35959, I/A 39 (17.08.15).

21 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUSTI MONTALVO RAFAEL;VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO. Presidente: AGUSTIMONTALVO RAFAEL. Cons.Del.Sol: AGUSTI MONTALVO RAFAEL. Cons.Del.Man: VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO.

29 de Enero de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 25.440,00 Euros. Resultante Suscrito: 275.600,00 Euros. Datos registrales. T 28324 , F27, S 8, H M 35959, I/A 36 (20.01.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS. Secretario: MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS. Cons.Del.Man:MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 28324 , F 28, S 8, H M 35959, I/A 37 (20.01.14).

21 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: BALLESTEROS RUIZ IGNACIO. Otros conceptos: QUEDA REVOCADO IGUALMENTE LAAMPLIACION DE PODER A FAVOR DEDON IGNACIO BALLESTEROS RUIZ MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA ANTE ELNOTARIO DE MADRID DON CARLOS DEL MORAL CARRO, EL DIA 28 DE MAYO DE 2004, CON EL NUMERO 3.568 DE ORDENDE PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 28& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 28324 , F 27, S 8, H M 35959,I/A 35 (13.06.13).

11 de Junio de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 187.440,00 Euros. Desembolsado: 187.440,00 Euros. Resultante Suscrito: 301.040,00 Euros.Resultante Desembolsado: 301.040,00 Euros. Cambio de objeto social. a).- LA REALIZACION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES,REFORMA, REHABILITACION, CONSERVACION, MODIFICACION Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE EDIFICACIONESBIENCON MEDIOS PROPIOS, BIEN SUBCONTRANTO DETERMINADAS ACTIVIDADES CON TERCERAS PERSONAS FISICAS OJURIDICAS.. Datos registrales. T 28324 , F 26, S 8, H M 35959, I/A 34 (30.05.12).

23 de Diciembre de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 113.600,00 Euros. Datos registrales. T 2016 , F 225,S 8, H M 35959, I/A 33 (13.12.10).

29 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUSTI MONTALVO RAFAEL. Presidente: AGUSTI MONTALVO RAFAEL. Consejero: AGUSTIMONTALVO JOSE LUIS. Secretario: AGUSTI MONTALVO JOSE LUIS. Consejero: MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS;VELASCOCACERES JUAN FRANCISCO. Cons.Del.Sol: AGUSTI MONTALVO RAFAEL. Cons.Del.Man: AGUSTI MONTALVO JOSELUIS;MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS;VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: AGUSTIMONTALVO RAFAEL;MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS;VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO.Presidente: AGUSTI MONTALVORAFAEL. Secretario: MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: AGUSTI MONTALVO RAFAEL. Cons.Del.Man: MONTEROALVAREZ JOSE LUIS;VELASCO CACERES JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 2016 , F 224, S 8, H M 35959, I/A 32(16.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n