Buscador CIF Logo

Actos BORME Construcciones Deco Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Construcciones Deco Sa

Actos BORME Construcciones Deco Sa - A08619223

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Construcciones Deco Sa con CIF A08619223

🔙 Perfil de Construcciones Deco Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Construcciones Deco Sa

16 de Julio de 2020
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BNFIX PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40740 , F 170, S 8, H B 44290, I/A 51 (8.07.20).

06 de Noviembre de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. PRESIDENTE: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. CONSEJERO: SANCHEZGALLEGO ANTONIO MARIA. VICEPRESIDEN: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. CONSEJERO: GALLEGO CANUTFRANCINA. SECR.NO CONS: SOLE RIBO XAVIER. Nombramientos. ADM.UNICO: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16 Y 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE

23 de Julio de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BNFIX PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40740 , F 170, S 8, H B 44290, I/A 49(13.07.18).

22 de Junio de 2017
Nombramientos. CONSEJERO: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. PRESIDENTE: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. CONSEJERO:SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. VICEPRESIDEN: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. CONSEJERO: GALLEGOCANUT FRANCINA. SECR.NO CONS: SOLE RIBO XAVIER. Datos registrales. T 40740 , F 169, S 8, H B 44290, I/A 48 (15.06.17).

20 de Septiembre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 40740 , F 169, S 8, H B 44290,I/A 47 (12.09.16).

11 de Mayo de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40740 , F 169, S 8, H B 44290, I/A 46 (4.05.15).

02 de Abril de 2013
Revocaciones. APODERADO: CASTILLO RIBOT MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 40740 , F 168, S 8, H B 44290, I/A 45(20.03.13).

22 de Noviembre de 2012
Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 40740 , F 168, S 8, H B 44290, I/A44 ( 9.11.12).

13 de Agosto de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40740 , F 167, S 8, H B 44290, I/A 43 (2.08.12).

16 de Diciembre de 2011
Nombramientos. CONSEJERO: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. PRESIDENTE: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. CONSEJERO:SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. VICEPRESIDEN: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. CONSEJERO: GALLEGOCANUT FRANCINA. SECR.NO CONS: SOLE RIBO XAVIER. Modificaciones estatutarias. ART.29.-MODIFICACION DEL PLAZODE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datos registrales. T 40740 , F 167, S 8, H B 44290, I/A 42 ( 2.12.11).

13 de Octubre de 2011
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: CAÑELLAS ANTO ANTONIO. PRESIDENTE: CAÑELLAS ANTOANTONIO. CONSEJERO: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA. VICEPRESIDEN: SANCHEZ GALLEGO ANTONIO MARIA.CONSEJERO: GALLEGO CANUT FRANCINA. Datos registrales. T 22862 , F 193, S 8, H B 44290, I/A 33 N (19.09.11).

09 de Junio de 2010
Revocaciones. APODERADO: GALLEGO CANUT FRANCINA. Datos registrales. T 40740 , F 166, S 8, H B 44290, I/A 40(27.05.10).

Nombramientos. APODERADO: CASTILLO RIBOT MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 40740 , F 166, S 8, H B 44290, I/A 41(27.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información