Actos BORME de Construcciones Urrutia Sa
12 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTEZO GARCIA JUAN. Presidente: CORTEZO GARCIA JUAN. Consejero: CALAVERA VAYAJOSE. Secretario: CALAVERA VAYA JOSE. Consejero: GUADAHERMOSA PROYECTOS URBANISTICOS 2001 S.L. Con.Delegado:CORTEZO GARCIA JUAN. Representan: COBO MORAL PABLO. Nombramientos. Adm. Unico: GUADAHERMOSA PROYECTOSURBANISTICOS 2001 S.L. Representan: COBO MORAL PABLO. Otros conceptos: Se modifican los artículos 24º, 25º, 26º, 27º, 29ºy 30º de los Estatutos Sociales. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datosregistrales. T 1727 , F 49, S 8, H VI 1394, I/A 45 ( 2.05.23).
27 de Octubre de 2022Otros conceptos: Se revoca el nombramiento de TEST AUDITORES-CONSULTORES, S.L., como auditor de cuentas de la sociedad"CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A." para el ejercicio 2.021, al concurrir justa causa y se nombra en su sustitución a "BAKER TILLYAUDITORES, S.L.P.", para los ejecicios 2021, 2022 y 2.023.- Datos registrales. T 1727 , F 49, S 8, H VI 1394, I/A 44 (18.10.22).
16 de Marzo de 2022Nombramientos. Con.Delegado: CORTEZO GARCIA JUAN. Datos registrales. T 1727 , F 48, S 8, H VI 1394, I/A 43 (22.02.22).
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTEZO GARCIA JUAN. Con.Delegado: CORTEZO GARCIA JUAN. Presidente: CORTEZOGARCIA JUAN. Consejero: CALAVERA VAYA JOSE. Secretario: CALAVERA VAYA JOSE. Consejero: URIARTE GONZALEZ BILBAOADELINA. Nombramientos. Representan: COBO MORAL PABLO. Consejero: CORTEZO GARCIA JUAN. Presidente: CORTEZOGARCIA JUAN. Consejero: CALAVERA VAYA JOSE. Secretario: CALAVERA VAYA JOSE. Consejero: GUADAHERMOSAPROYECTOS URBANISTICOS 2001 S.L. Datos registrales. T 1727 , F 48, S 8, H VI 1394, I/A 42 (24.12.21).
29 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO SANTILLAN AINARA. Datos registrales. T 1285 , F 172, S 8, H VI 1394, I/A 41 (12.07.21).
17 de Febrero de 2021Ampliación de capital. Suscrito: 38.075,16 Euros. Desembolsado: 38.075,16 Euros. Resultante Suscrito: 148.408,98 Euros.Resultante Desembolsado: 148.408,98 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 1285 , F 172, S 8, H VI 1394, I/A 40 ( 3.02.21).
15 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: DEL CARRE RUBIO JUAN CARLOS EMILIO. Datos registrales. T 1285 , F 168, S 8, H VI 1394, I/A 38(23.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GIL AGUIRRE EDUARDO. Datos registrales. T 1285 , F 170, S 8, H VI 1394, I/A 39 (23.11.20).
31 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: TEST AUDITORES-CONSULTORES S.L. Datos registrales. T 1285 , F 168, S 8, H VI 1394, I/A 37(14.01.20).
01 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: TEST AUDITORES-CONSULTORES S.L. Datos registrales. T 1285 , F 167, S 8, H VI 1394, I/A 36 (9.11.17).
27 de Noviembre de 2017Reducción de capital. Importe reducción: 18.406,50 Euros. Resultante Suscrito: 110.333,82 Euros. Datos registrales. T 1285 , F167, S 8, H VI 1394, I/A 35 (31.10.17).
08 de Noviembre de 2016Reelecciones. Consejero: CORTEZO GARCIA JUAN. Con.Delegado: CORTEZO GARCIA JUAN. Presidente: CORTEZO GARCIAJUAN. Consejero: CALAVERA VAYA JOSE. Secretario: CALAVERA VAYA JOSE. Consejero: URIARTE GONZALEZ BILBAOADELINA. Datos registrales. T 1285 , F 166, S 8, H VI 1394, I/A 34 (24.10.16).
18 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: URCELAY CALLEJA ESTEBAN ANGEL. Datos registrales. T 1285 , F 166, S 8, H VI 1394, I/A 33 (3.11.14).
26 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: DEL CARRE RUBIO JUAN CARLOS EMILIO. Datos registrales. T 1285 , F 166, S 8, H VI 1394, I/A32 ( 8.10.12).
13 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MUÑIZ FERNANDEZ GABRIEL;PAGALDAY URIBE FRANCISCO JAVIER;AGRA MARTINROBERTO. Vicepresid.: AGRA MARTIN ROBERTO. Reelecciones. Consejero: CORTEZO GARCIA JUAN. Con.Delegado:
24 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: URIARTE URRUTIA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: URIARTE GONZALEZ BILBAOADELINA. Datos registrales. T 1285 , F 165, S 8, H VI 1394, I/A 30 ( 2.11.10).
03 de Noviembre de 2010Reelecciones. Consejero: CALAVERA VAYA JOSE. Secretario: CALAVERA VAYA JOSE. Datos registrales. T 1285 , F 164, S 8, HVI 1394, I/A 29 (15.10.10).