Actos BORME de Construcciones Y Depuraciones Sociedad Anonima
20 de Febrero de 2023Otros conceptos: "ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP.", con NIF B28266526, designa como representante persona f铆sica a donGuillermo Ramos Gonz谩lez, con D.N.I. 25.065.852-S. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 824/2022. FIRME: Si, Fecha deresoluci贸n 10/11/2022. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DESEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDON CODESIDO. Resoluciones: Practicada INSCRIPCION DE LA DECLARACION DECONCURSO VOLUNTARIO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 824/2022. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 10/11/2022.Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado:num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDON CODESIDO. Resoluciones:INTERVENCION. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 824/2022. Fecha de resoluci贸n 10/11/2022. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE SEVILLA. Juez: JESUS GINES GABALDONCODESIDO. Administrador Concursal. Fecha 10/11/2022, NIF/CIF B28266526. ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP. Datosregistrales. T 6394 , F 80, S 8, H SE 529, I/A 87 (10.02.23).
05 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTRO CAMPOS RAFAEL. Apo.Manc.: ALDAY MENDIZABAL ANGEL. Datos registrales. T 6394, F 78, S 8, H SE 529, I/A 86 (28.03.22).
25 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6394 , F 78, S 8, H SE 529, I/A85 (18.03.22).
22 de Marzo de 2022Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2020 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6394 , F 78, S 8, H SE 529, I/A 84(15.03.22).
17 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Apo.Sol.: SALAS ORTA JORGE;HEREZA DIAZ LUIS;MERELLOPEREZ BARBADILLO MARIA. Apoderado: RUIZ PA脩OS MARIA ELENA. Apo.Man.Soli: DEL CORRAL BERAZA JULEN. Apo.Manc.:ALDAY MENDIZABAL ANGEL;SALAS ORTA JORGE;HEREZA DIAZ LUIS;ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Otros conceptos:REVOCA LA TOTALIDAD DE LOS PODERES OTORGADOS, EN NOMBRE Y PRESENTACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DECUALQUIERA DE SUS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y/O SUCURSALES, AFAVOR DE JORGE SALAS ORTA Y PEDRO ALMAGRO GAVILAN , CON ANTERIORIDAD AL DIA 25/01/2022.- REVOCA LATOTALIDAD DE LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD, ASI COMO DE CUALQUIERA DE SUS UNIONESTEMPORALES DE EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y/O SUCURSALES, A FAVOR DE LUIS HEREZA DIAZ,MARIA MERELLO PEREZ-BARBADILLO Y MARIA ELENA RUIZ PA脩OS, CON ANTERIORIDAD AL DIA 25/01/2022.- Datosregistrales. T 6394 , F 77, S 8, H SE 529, I/A 83 ( 9.03.22).
19 de Julio de 2021Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2019 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 6394 , F 77, S 8, H SE 529, I/A 81 ( 6.07.21).
Otros conceptos: CAMBIADO el representante persona f铆sica de la entidad "ABENGOA ABENEWCO 1, S.A.", administradora 煤nicade "CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SOCIEDAD ANONIMA", renuncia don Joaqu铆n Fern谩ndez de Pi茅rola Mar铆n, y senombra a DON JUAN PABLO LOPEZ-BRAVO VELASCO, con D.N.I. n煤mero 50.694.706-S.- Datos registrales. T 6394 , F 77, S 8, HSE 529, I/A 82 ( 8.07.21).
19 de Noviembre de 2020Otros conceptos: REVOCADAS las facultades solidarias identificadas con la letra "F", enumeradas de la 1 a la 7, otorgadas a favorde don Julen del Corral Beraza en virtud de escritura de fecha 15 de septiembre de 2020, autorizada por el Notario de Sevilla don Jos茅Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, 1.647 de protocolo. Datos registrales. T 6394 , F 76, S 8, H SE 529, I/A 80 (11.11.20).
22 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL CORRAL BERAZA JULEN. Apo.Manc.: ALDAY MENDIZABAL ANGEL;SALAS ORTAJORGE;HEREZA DIAZ LUIS;ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Datos registrales. T 6394 , F 74, S 8, H SE 529, I/A 79 (15.10.20).
21 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: RUIZ GARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 6394 , F 74, S 8, H SE 529, I/A 78 (13.11.19).
11 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALDAY MENDIZABAL ANGEL. Datos registrales. T 6394 , F 72, S 8, H SE 529, I/A 76 ( 2.07.19).
10 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: RUIZ PA脩OS MARIA ELENA. Datos registrales. T 6394 , F 73, S 8, H SE 529, I/A 77 ( 2.07.19).
03 de Mayo de 2019Modificaciones estatutarias. 22潞: ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 6394 , F 71, S 8, H SE 529, I/A 75(24.04.19).
23 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABENGOA AGUA SA. Nombramientos. Adm. Unico: ABENGOA ABENEWCO 1 SA. Otrosconceptos: La entidad administradora 煤nica de la sociedad de referencia, designa a DON JOAQUIN FERNANDEZ DE PIEROLAMARIN como representante persona fisica para el ejercicio de tal cargo. Datos registrales. T 6394 , F 70, S 8, H SE 529, I/A 74(10.04.19).
08 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Apo.Sol.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO;SALAS ORTA JORGE;SALGADODEVINCENZI MARTIN;MEDINA ECHEVARRIA MANUEL. Apo.Manc.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Apo.Sol.: BALBOA LINARESSALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Apo.Sol.: RUFO CAMPILLOPEDRO;MERELLO PEREZ BARBADILLO MARIA;ALMAGRO GAVILAN PEDRO;MERELLO PEREZ BARBADILLO MARIA.Apo.Man.Soli: CEBOLLA ZARZUELA NATALIA;HEREZA DIAZ LUIS. Apo.Manc.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO;SALAS ORTAJORGE;MEDINA ECHEVARRIA MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALMAGRO GAVILAN PEDRO;CEBOLLA ZARZUELANATALIA. Apoderado: BALBOA LINARES SALVADOR;RUFO CAMPILLO PEDRO;HURTADO GONZALEZ MARIA LUZ. Apo.Sol.:SALAS ORTA JORGE;HEREZA DIAZ LUIS;MERELLO PEREZ BARBADILLO MARIA. Datos registrales. T 6394 , F 67, S 8, H SE529, I/A 73 ( 1.02.19).
31 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Nombramientos. Adm. Unico:ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD A. Datos registrales. T 6394 , F 67, S 8, H SE 529, I/A 72(22.08.18).
16 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: DE VERGARA PARDEIRO ALBERTO;VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Manc.: VALDIVIA BORREROLUCIA. Apo.Sol.: VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Manc.: VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Sol.: VALDIVIA BORREROLUCIA;VALDIVIA BORRERO LUCIA. Datos registrales. T 6394 , F 67, S 8, H SE 529, I/A 71 ( 8.11.17).
14 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: CEBOLLA ZARZUELA NATALIA;HEREZA DIAZ LUIS. Apo.Manc.: ALMAGRO GAVILANPEDRO;SALAS ORTA JORGE;MEDINA ECHEVARRIA MANUEL. Datos registrales. T 6394 , F 65, S 8, H SE 529, I/A 70 ( 3.11.17).
05 de Octubre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: ESTEFANELL JARA VALENTIN. Apo.Manc.: ESTEFANELL JARA VALENTIN. Apo.Sol.: ROMERO LOPEZALBERTO;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Manc.: VALDIVIA BORREROLUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;VALDIVIA BORREROLUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;VALDIVIA BORREROLUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS. Apo.Sol.: ROMEROLOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS. Apo.Manc.: GERARDO LANGONE ROCCO;PAPERAN SACCONE EDUARDOANDRES;VALDIVIA BORRERO LUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVOCARLOS;PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES;GERARDO LANGONE ROCCO;VALDIVIA BORRERO LUCIA;MURILLOFERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;PAPERAN SACCONE EDUARDOANDRES;GERARDO LANGONE ROCCO;VALDIVIA BORRERO LUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZALBERTO. Apo.Man.Soli: VALDIVIA BORRERO LUCIA;GONZALEZ BRAVO CARLOS;ABASCAL MONTES CRISTOBAL;LAFFONBENJUMEA ANGEL MARIA;BATANERO ORTIZ JOSE MARIA. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLOSANTIAGO. Apo.Manc.: VALDIVIA BORRERO LUCIA;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;JIMENEZ-VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL;ALAMINOS ECHARRI DANIEL;SANTANA VALENCIA MARIA DEL SOL;GARCIA HERNANDEZ IGNACIO;ARTAZABILBAO FERNANDO. Datos registrales. T 6394 , F 64, S 8, H SE 529, I/A 69 (22.09.17).
18 de Agosto de 2017Modificaciones estatutarias. 9 BIS. Prenda de Acciones.-. Datos registrales. T 6394 , F 64, S 8, H SE 529, I/A 68 ( 7.08.17).
07 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ALMAGRO GAVILAN PEDRO. Apo.Sol.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO;SALAS ORTA JORGE;DEVERGARA PARDEIRO ALBERTO;SALGADO DEVINCENZI MARTIN;VALDIVIA BORRERO LUCIA;MEDINA ECHEVARRIA MANUEL.Apo.Manc.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO;VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Sol.: VALDIVIA BORRERO LUCIA;BALBOA LINARESSALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: ALMAGRO GAVILAN PEDRO;VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Sol.:VALDIVIA BORRERO LUCIA;RUFO CAMPILLO PEDRO;MERELLO PEREZ BARBADILLO MARIA;ALMAGRO GAVILANPEDRO;VALDIVIA BORRERO LUCIA;MERELLO PEREZ BARBADILLO MARIA. Datos registrales. T 6049 , F 80, S 8, H SE 529, I/A66 (27.06.17).
Revocaciones. Apo.Manc.: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;SALGADODEVINCENZI MARTIN JOSE. Apo.Man.Soli: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE. Apo.Manc.: SALGADO DEVINCENZI MARTINJOSE. Datos registrales. T 6394 , F 64, S 8, H SE 529, I/A 67 (27.06.17).
21 de Abril de 2017Otros conceptos: A los efectos de lo establecido en el articulo 122.3 del R.R.Ml, se hace constar que con fecha 3 de marzo de 2017,se pusieron en circulaci贸n un t铆tulo m煤ltiple. Titulo m煤ltiple n煤mero 1 , representativo de la totalidad de las acciones en que se divide elcapital social de esta sociedad. Datos registrales. T 417, L 239, F 197, S 8, H SE 529, I/A 37 (12.04.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: LAFFON BENJUMEA ANGEL. Datos registrales. T 6049 , F 79, S 8, H SE 529, I/A 65 (12.01.17).
16 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;LAFFON BENJUMEAANGEL MARIA. Apo.Sol.: MIHURA CARRION MARIA DEL MAR;JORDANA AGUSTIN CARLOS;MARTIN DE PORRESELISA;BLANCAS CASAS ALMUDENA;MAURITS DE CONINCK ANN SIMONA;BLANCO POLONIO JOSE CARLOS;GONZALEZBRAVO CARLOS;BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: JIMENEZ VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE;PEREZ ALONSO AIDA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;VALDIVIA BORRERO LUCIA;GONZALEZ BRAVOCARLOS;ABASCAL MONTES CRISTOBAL;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA;BATANERO ORTIZ JOSE MARIA. Apo.Sol.:BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;VALDIVIABORRERO LUCIA;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;ALAMINOS ECHARRIDANIEL;SANTANA VALENCIA MARIA DEL SOL;GARCIA HERNANDEZ IGNACIO;ARTAZA BILBAO FERNANDO. Datos registrales.T 6049 , F 77, S 8, H SE 529, I/A 64 ( 9.09.16).
05 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES. Datos registrales. T 6049 , F 77, S 8, H SE 529, I/A 63(29.07.16).
07 de Julio de 2016Nombramientos. Adm. Unico: ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA. Modificaciones estatutarias. 7.Funcionamiento Junta General.-. 22. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. 23. Mandato. Terminaci贸n.-. 24. Sincontenido.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 6049 , F 76, S 8, H SE 529, I/A 62 (28.06.16).
13 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA;POLO GUERRERO ALVARO;SALGADO DEVINCENZIMARTIN JOSE.Presidente: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE. SecreNoConsj: SALINAS I脩IGO PURIFICACION. Datosregistrales. T 6049 , F 76, S 8, H SE 529, I/A 61 (28.04.16).
20 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5076 , F 225, S 8, H SE 529, I/A 60 (11.01.16).
25 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ NAVARRO MANUEL. Datos registrales. T 5076 , F 225, S 8, H SE 529, I/A 59 (17.06.15).
22 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS. Apo.Manc.: GERARDO LANGONEROCCO;SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES;VALDIVIA BORREROLUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;PAPERAN SACCONEEDUARDO ANDRES;SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;GERARDO LANGONE ROCCO;VALDIVIA BORREROLUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;PAPERAN SACCONEEDUARDO ANDRES;SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;GERARDO LANGONE ROCCO;VALDIVIA BORREROLUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS. Datos registrales. T5076 , F 224, S 8, H SE 529, I/A 58 (15.04.15).
07 de Enero de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;VALDIVIA BORRERO LUCIA. Apo.Manc.: VALDIVIABORRERO LUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;VALDIVIABORRERO LUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS;VALDIVIABORRERO LUCIA;MURILLO FERNANDEZ JOSE ALBERTO;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZ BRAVO CARLOS. Datosregistrales. T 5076 , F 223, S 8, H SE 529, I/A 57 (22.12.14).
28 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO. Consejero: ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO.Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;LAFFON BENJUMEA ANGELMARIA. Apo.Manc.: SANCHEZ NAVARRO MANUEL;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA;ALVAREZ CATALAN ANDRESNEMESIO;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO;LAFFON BENJUMEA ANGELMARIA;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA;ALVAREZ CATALANANDRES NEMESIO;ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO;SANCHEZ NAVARRO MANUEL. Apo.Sol.: MIHURA CARRION MARIADEL MAR;JORDANA AGUSTIN CARLOS;MARTIN DE PORRES ELISA;BLANCAS CASAS ALMUDENA;MAURITS DE CONINCK ANNSIMONA;RUIZ PA脩OS MARIA ELENA;BLANCO POLONIO JOSE CARLOS;ROMERO LOPEZ ALBERTO;SANCHEZ NAVARROMANUEL;BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUELANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE;CERROREDONDO JOSE FERNANDO. Apo.Sol.: SANTOS GARCIA JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: SALGADO DEVINCENZIMARTIN JOSE. Presidente: SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE. Apo.Man.Soli: PAPERAN SACCONE EDUARDOANDRES;SALGADO DEVINCENZI MARTIN JOSE;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA. Apo.Sol.:MIHURA CARRION MARIA DEL MAR;JORDANA AGUSTIN CARLOS;MARTIN DE PORRES ELISA;BLANCAS CASASALMUDENA;MAURITS DE CONINCK ANN SIMONA;BLANCO POLONIO JOSE CARLOS;ROMERO LOPEZ ALBERTO;GONZALEZBRAVO CARLOS;BALBOA LINARES SALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: JIMENEZ VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL;GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL;MONTOYA CAZORLA MARIA JOSE;PEREZ ALONSO AIDA. Datosregistrales. T 5076 , F 219, S 8, H SE 529, I/A 56 (17.10.14).
12 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SALINAS I脩IGO PURIFICACION. SecreNoConsj: HOOGSTRAATE MAARTEN.Nombramientos. SecreNoConsj: SALINAS I脩IGO PURIFICACION. Datos registrales. T 5076 , F 219, S 8, H SE 529, I/A 55(30.04.14).
21 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO;MU脩OZ DONAT JOSE IGNACIO;VALVERDE DELGADOMANUEL JESUS;CEBOLLA ZARZUELA NATALIA. Presidente: BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Revocaciones. Apo.Man.Soli:BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Apo.Manc.: BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Apo.Sol.: BALBOA LINARESSALVADOR;CORREA PORTILLO SANTIAGO;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA. Apo.Manc.: LAFFON BENJUMEA ANGEL
25 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CA脩AS VELA ALEJANDRO. Revocaciones. Apoderado: CA脩AS VELA ALEJANDRO.Apo.Manc.: ESTEFANELL JARA VALENTIN;ESTEFANELL JARA VALENTIN. Nombramientos. SecreNoConsj: LUNA GARCIAJOSE LUIS. Datos registrales. T 5076 , F 212, S 8, H SE 529, I/A 51 (15.10.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTEFANELL JARA VALENTIN. Nombramientos. Consejero: MU脩OZ DONAT JOSE IGNACIO.Datos registrales. T 5076 , F 213, S 8, H SE 529, I/A 52 (15.10.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ NAVARRO MANUEL;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA. Nombramientos. Consejero:VALVERDE DELGADO MANUEL JESUS;CEBOLLA ZARZUELA NATALIA. Datos registrales. T 5076 , F 213, S 8, H SE 529, I/A 53(15.10.12).
06 de Septiembre de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5076 , F 212, S 8, H SE 529, I/A 50 (24.08.12).
23 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: PEREZ ALONSO AIDA. Nombramientos. SecreNoConsj: CA脩AS VELA ALEJANDRO. Datosregistrales. T 5076 , F 211, S 8, H SE 529, I/A 49 (13.09.11).
14 de Junio de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -CAMPUS PALMAS ALTAS. CODIGO P (SEVILLA). Datos registrales. T 5076 , F 211, S 8, H SE 529, I/A 48 ( 3.06.11).
09 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: CA脩AS VELA ALEJANDRO. Datos registrales. T 5076 , F 210, S 8, H SE 529, I/A 47 (31.08.10).
21 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5076 , F 210, S 8, H SE 529, I/A46 ( 9.12.09).
09 de Septiembre de 2009Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE LA BUHAIRA 2(SEVILLA). Datos registrales. T 5076 , F 210, S 8, H SE 529, I/A 45 (27.08.09).
29 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: FI脩ANA GUZMAN ANTONIO. Apo.Manc.: BARCELO PINZON FEDERICO;BRAVO MANCHE脩OGUILLERMO;LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA;ESTEFANELL JARA VALENTIN. Datos registrales. T 3417 , F 201, S 8, H SE529, I/A 44 (15.07.09).
23 de Julio de 2009Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. "Art铆culo 2潞. Objeto social. LaSociedad tendr谩 por objeto la organizaci贸ny explotaci贸n de actividades y negocios, tanto p煤blicos como privados, queguarden relaci贸ncon: 1.- La construcci贸n, reparaci贸n, rehabilitaci贸n, consolidaci贸n, restauraci贸n, decoraci贸n, ornamentaci贸n, conservaci贸n y manteni.Datos registrales. T 3417 , F 201, S 8, H SE 529, I/A 43 (10.07.09).
20 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLER SALCEDO SALVADOR. Revocaciones. Apo.Manc.: SOLER SALCEDO SALVADOR.Apo.Sol.: SOLER SALCEDO SALVADOR. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ NAVARRO MANUEL. Datos registrales. T 3417, F 198, S 8, H SE 529, I/A 39 ( 4.05.09).
Reelecciones. Consejero: BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Presidente: BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Datos registrales. T3417 , F 198, S 8, H SE 529, I/A 40 ( 4.05.09).
Revocaciones. Apo.Manc.: ESTEFANELL JARA VALENTIN;BARCELO PINZON FEDERICO;BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO.Nombramientos. Apo.Sol.: LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA. Apo.Manc.: LAFFON BENJUMEA ANGEL MARIA;SANCHEZNAVARRO MANUEL;ESTEFANELL JARA VALENTIN;BARCELO PINZON FEDERICO;BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Datosregistrales. T 3417 , F 198, S 8, H SE 529, I/A 41 ( 4.05.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: MEDINA ECHEVARRIA MANUEL;SANCHEZ NAVARRO MANUEL. Apo.Manc.: MEDINA ECHEVARRIAMANUEL;SANCHEZ NAVARRO MANUEL;COSIN FERNANDEZ CARLOS;ESTEFANELL JARA VALENTIN;BARCELO PINZONFEDERICO;BRAVO MANCHE脩O GUILLERMO. Datos registrales. T 3417 , F 200, S 8, H SE 529, I/A 42 ( 4.05.09).
03 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3417 , F 197, S 8, H SE 529, I/A 38 (19.02.09).
03 de Febrero de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.999.990,29 Euros. Desembolsado: 3.999.990,29 Euros. Resultante Suscrito: 4.150.243,29 Euros.Resultante Desembolsado: 4.150.243,29 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 3417 , F 197, S 8, H SE 529, I/A 37 (22.01.09).