Actos BORME de Constructora De Castrillon Sa
22 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: ROMERO FERNANDEZ MANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Datos registrales. T 1914 , F 216, S 8, HAS 7221, I/A 76 (11.08.23).
02 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MONCADA ESTEBAN-INFANTES ANTONIO LUCIANO;CUERVO GARCIA LUIS ENRIQUE. Datosregistrales. T 1914 , F 216, S 8, H AS 7221, I/A 75 (25.10.22).
23 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ABARCA JUNCO I脩IGO. SecreNoConsj: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL.Nombramientos. SecreNoConsj: HEVIA AZA SUAREZ JOSE MANUEL. Consejero: NAVALPOTRO FUSTER CARLOS ANTONIO.Datos registrales. T 1914 , F 187, S 8, H AS 7221, I/A 74 (15.04.21).
13 de Agosto de 2020Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Objeto social.-. Cambio de objeto social. CNAE: 4122. 1. La adquisici贸nde terrenos y bienes inmuebles en general, urbanos y r煤sticos, para la promoci贸n, gesti贸n, desarrollo y ejecuci贸n de negociosinmobiliarios, y entre ellos, la urbanizaci贸n, parcelaci贸n y edificaci贸n para su posterior explotaci贸n, venta o arrendamiento. 2. Elestudio, re. Datos registrales. T 1914 , F 187, S 8, H AS 7221, I/A 73 ( 6.08.20).
17 de Febrero de 2020Reelecciones. SecreNoConsj: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1914 , F 187, S 8, H AS 7221, I/A72 (10.02.20).
25 de Septiembre de 2018Reelecciones. Consejero: ARIAS ZAPICO JAIME LUIS;ABARCA JUNCO I脩IGO. Datos registrales. T 1914 , F 187, S 8, H AS 7221,I/A 70 (17.09.18).
Reelecciones. Presidente: ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Datos registrales. T 1914 , F 187, S 8, H AS 7221, I/A 71 (17.09.18).
02 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: LEON JARIEGO JUAN. Nombramientos. Consejero: ROMERO FERNANDEZ MANUEL. Datosregistrales. T 1914 , F 187, S 8, H AS 7221, I/A 69 (26.01.18).
03 de Octubre de 2017Reelecciones. Consejero: LEON JARIEGO JUAN. Datos registrales. T 1914 , F 186, S 8, H AS 7221, I/A 68 (19.09.17).
22 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: ALVAREZ DAVILA MANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS;LEON JARIEGO JUAN;ALVAREZ DAVILAMANUEL;ARIAS ZAPICO JAIME LUIS;LEON JARIEGO JUAN. Datos registrales. T 1914 , F 186, S 8, H AS 7221, I/A 67 (14.09.16).
16 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: FIGAREDO DE LA MORA CESAR. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ FERNANDEZJOSE MANUEL. Datos registrales. T 1914 , F 186, S 8, H AS 7221, I/A 66 ( 6.03.15).
25 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ DAVILA MANUEL. Revocaciones. Con.Delegado: ARIAS ZAPICO JAIME LUIS.Nombramientos. Consejero: ABARCA JUNCO I脩IGO. Reelecciones. Consejero: ARIAS ZAPICO JAIME LUIS. Datos registrales.T 1914 , F 186, S 8, H AS 7221, I/A 65 (17.09.13).
05 de Diciembre de 2012Reelecciones. Consejero: LEON JARIEGO JUAN;ALVAREZ DAVILA MANUEL. Datos registrales. T 1914 , F 186, S 8, H AS 7221,I/A 64 (23.11.12).
29 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: CUERVO GARCIA LUIS ENRIQUE. Apo.Sol.: CUERVO GARCIA LUIS ENRIQUE. Apo.Manc.: CORONELFERNANDEZ JUAN FRANCISCO. Apo.Sol.: CORONEL FERNANDEZ JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Manc.: CUERVOGARCIA LUIS ENRIQUE. Apo.Sol.: CUERVO GARCIA LUIS ENRIQUE. Apo.Manc.: MONCADA ESTEBAN-INFANTES ANTONIOLUCIANO. Apo.Sol.: MONCADA ESTEBAN-INFANTES ANTONIO LUCIANO. Datos registrales. T 1914 , F 183, S 8, H AS 7221, I/A63 (18.11.11).
06 de Octubre de 2009Modificaciones estatutarias. 17. Funcionamiento Junta Gral.-. 28. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 1914 , F158, S 8, H AS 7221, I/A 62 (24.09.09).