Buscador CIF Logo

Actos BORME Consultants In Business Engineering Research Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Consultants In Business Engineering Research Sl

Actos BORME Consultants In Business Engineering Research Sl - B62263272

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Consultants In Business Engineering Research Sl con CIF B62263272

馃敊 Perfil de Consultants In Business Engineering Research Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Consultants In Business Engineering Research Sl

12 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MEZGER CHRISTIAN-MICHAEL. Nombramientos. Liquidador: MEZGER CHRISTIAN-MICHAEL.Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 31507 , F 197, S 8, H M 566194, I/A 18 ( 5.02.18).

13 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SL. Datos registrales. T 31507 , F 196, S 8, H M 566194, I/A 17 ( 4.10.17).

25 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MEZGER CHRISTIAN-MICHAEL;RADCLIFFE MICHAEL-SEAN. Nombramientos. Adm. Unico:MEZGER CHRISTIAN-MICHAEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 31507 , F 196, S 8, H M 566194, I/A 16 (16.08.17).

22 de Marzo de 2017
Otros conceptos: Se revoca las facultades n煤mero 1 a 11, ambas inclusive, y 13 a 16, ambas inclusive del poder otorgado a favor deD. Carlos Bascu帽ana y D. Carlos Alonso Gonz谩lez en virtud de escritura que caus贸 la inscripci贸n 7陋. Datos registrales. T 31507 , F195, S 8, H M 566194, I/A 15 (14.03.17).

01 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31507 , F 195, S 8, H M 566194, I/A 14 (22.02.17).

25 de Enero de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social .-. Cambio de domicilio social. C/ VIA DE LOSPOBLADOS 1 - EDIFICIO C, PLANTA 4陋, (MADRID). Datos registrales. T 31507 , F 195, S 8, H M 566194, I/A 13 (18.01.17).

24 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31507 , F 195, S 8, H M 566194, I/A 12 (14.10.16).

20 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31507 , F 194, S 8, H M 566194, I/A 11 (13.01.15).

27 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31507 , F 194, S 8, H M 566194, I/A 10 (19.08.14).

21 de Enero de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CIBER INTERNATIONAL BV. Datos registrales. T 31507 , F 194, S8, H M 566194, I/A 9 (13.01.14).

27 de Noviembre de 2013
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 7, 11, 14, 17, 23 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.NUEVA REDACCION DE LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS. . Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: CIBER SOLUTIONS SL. Datos registrales. T 31455 , F 194, S 8, H M 566194, I/A 8 (20.11.13).

12 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: BASCU脩ANA GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 31455 , F 190, S 8, H M 566194, I/A 6 ( 4.11.13).

Revocaciones. Apo.Sol.: BASCU脩ANA GARCIA CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO GONZALEZCARLOS;BASCU脩ANA GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 31455 , F 192, S 8, H M 566194, I/A 7 ( 4.11.13).

29 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 31455 , F 190, S 8, H M 566194, I/A 5 (21.10.13).

28 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 31455 , F 188, S 8, H M 566194, I/A 4 (18.10.13).

24 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apoderado: BASCU脩ANA GARCIA CARLES. Datos registrales. T 31455 , F 188, S 8, H M 566194, I/A 3 (17.10.13).

11 de Octubre de 2013
Cambio de domicilio social. PLAZA MANUEL GOMEZ MORENO 2 3潞 B - ZONA AZCA - EDI (MADRID). Datos registrales. T31455 , F 188, S 8, H M 566194, I/A 2 ( 4.10.13).

30 de Agosto de 2013
Revocaciones. SECR.NO CONS: JANE BRU JORDI. CONSEJERO: THOMAS JOHANNES CORNELIS VAN DEN BERG.PRESIDENTE: THOMAS JOHANNES CORNELIS VAN DEN BERG. CONSEJERO: ALONSO GONZALEZ CARLOS;BASCU脩ANAGARCIA CARLOS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MICHAEL SEAN RADCLIFFE;CHRISTIAN MICHAEL MEZGER. Datosregistrales. T 42780 , F 155, S 8, H B 211126, I/A 44 (21.08.13).

Revocaciones. APODERADO: FRUHBECK OLMEDO FEDERICO;AUGUST KELLER;BASCU脩ANA GARCIA CARLOS;ALONSOGONZALEZ CARLOS. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: BASCU脩ANA GARCIA CARLES. Datos registrales. T 42780 , F 155, S8, H B 211126, I/A 45 (21.08.13).

05 de Abril de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42780 , F 154, S 8, H B 211126, I/A 43 (27.03.13).

30 de Enero de 2013
Cambio de objeto social. AMPLIAR A:VENTA DE LICENCIAS.LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA INCLUYEN LA REALIZACIONDE ESTUDIOS FINANCIEROS,ECONOMICOS,ANALISIS DE MERCADO,PENETRACION DE MARCA,ESTUDIOS DE PROMOCIONDE PRODUCTOS,ACUTACIONES PARA LA VALORACION... Datos registrales. T 42780 , F 153, S 8, H B 211126, I/A 42(22.01.13).

31 de Mayo de 2012
Revocaciones. APODERADO: DIAZ FERNANDEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 42780 , F 153, S 8, H B 211126, I/A 41(22.05.12).

23 de Mayo de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: DIAZ FERNANDEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 42780 , F 153, S 8, H B 211126, I/A 40(10.05.12).

06 de Marzo de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42780 , F 153, S 8, H B 211126, I/A 39 (22.02.12).

05 de Diciembre de 2011
Nombramientos. APODERADO: DIAZ FERNANDEZ JUAN CARLOS;ALONSO GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 42780 ,F 151, S 8, H B 211126, I/A 38 (23.11.11).

31 de Agosto de 2011
Revocaciones. APODERADO: DE LA FUENTE DIAZ JUAN PABLO. CONSEJERO: TERJE LAUGERUD. PRESIDENTE: TERJELAUGERUD. CONSEJERO: PETER JOHN HARRIS;DE LA FUENTE DIAZ JUAN PABLO;PAUL JOHN WILLIAMS. Nombramientos.CONSEJERO: PAUL JOHN WILLIAMS. APODERADO: BASCU脩ANA GARCIA CARLOS. CONSEJERO: THOMAS JOHANNESCORNELIS VAN DEN BERG. PRESIDENTE: THOMAS JOHANNES CORNELIS VAN DEN BERG. CONSEJERO: DIAZ FERNANDEZJUAN CARLOS;ALONSO GONZALEZ CARLOS;BASCU脩ANA GARCIA CARLOS. Datos registrales. T 35134 , F 204, S 8, H B211126, I/A 37 (18.08.11).

30 de Junio de 2011
Nombramientos. SECR.NO CONS: JANE BRU JORDI. Datos registrales. T 35134 , F 203, S 8, H B 211126, I/A 36 (17.06.11).

08 de Abril de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35134 , F 203, S 8, H B 211126, I/A 35 (25.03.11).

14 de Junio de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.650.800,00 Euros. Datos registrales. T 35134 , F 202, S 8,H B 211126, I/A 34 ( 1.06.10).

06 de Mayo de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35134 , F 202, S 8, H B 211126, I/A 33 (26.04.10).

01 de Diciembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35134 , F 202, S 8, H B 211126, I/A 32 (18.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n