Actos BORME de Consulting De Economistas Sa
07 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN LARA LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA.Cambio de denominaci贸n social. SUMAR-VAPA SA. Datos registrales. T 39139 , F 197, S 8, H M 138130, I/A 73 (30.09.22).
26 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MARCOS DE PAZ LOURDES MARIA. Datos registrales. T 39139 , F 195, S 8, H M 138130, I/A 72(19.07.21).
30 de Enero de 2020Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 24潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Datos registrales. T 39139 , F 195, S 8, H M 138130, I/A 70 (23.01.20).
05 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SUERO MARCOS PATRICIA;HERNANDEZ GARCIA MARIA JESUS;CARO ROMERO JOSE ARMANDO.Datos registrales. T 39139 , F 194, S 8, H M 138130, I/A 70 (29.07.19).
02 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: MORENO SERRANO IMANOL. Datos registrales. T 39139 , F 194, S 8, H M 138130, I/A 69 (26.07.19).
24 de Junio de 2019Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: CONSULTING DE ECONOMISTAS CENTRAL SL. Datos registrales. T 31745 , F 79,S 8, H M 138130, I/A 68 (17.06.19).
19 de Marzo de 2019Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del Art铆culo 22潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 31745 , F 79, S 8, H M
04 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: BENITO RECIO SANDRA. Datos registrales. T 31745 , F 79, S 8, H M 138130, I/A 66 (28.01.19).
18 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SUERO VALENZUELA CELESTINO. Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN LARA LUIS. Datosregistrales. T 31745 , F 78, S 8, H M 138130, I/A 65 (11.12.18).
17 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: PULIDO PORCEL CRISTINA. Datos registrales. T 31745 , F 78, S 8, H M 138130, I/A 64 (10.12.18).
07 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ZAMBRANO ROSERO KAYLA ESTEFANY. Datos registrales. T 31745 , F 77, S 8, H M 138130, I/A63 (29.11.18).
22 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MELERO GONZALEZ JOSE ANTONIO;YELA PIZARRO VERONICA;FERRANDEZ DE MU脩ICO ANAMARIA;GONZALEZ SAEZ EVA. Datos registrales. T 31745 , F 77, S 8, H M 138130, I/A 62 (15.11.18).
12 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: MOYANO DE LA IGLESIA PATRICIA. Datos registrales. T 31745 , F 76, S 8, H M 138130, I/A 60 (5.09.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: MORENO DEL PINO MARIA DE LAS MERCEDES;VIDAL RAMOS MARIA;REYES VALBUENAVICTOR;ROMERO ARBELAEZ BRENDA MARCELA;MOREA LORENZO YOLANDA. Datos registrales. T 31745 , F 77, S 8, H M138130, I/A 61 ( 5.09.18).
24 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ ROMERO ANTONIO;DIAZ PEREZ CARLOS. Datos registrales. T 31745 , F 75, S 8, H M138130, I/A 58 (16.04.18).
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ MILARA JAVIER. Datos registrales. T 31745 , F 76, S 8, H M 138130, I/A 59 (16.04.18).
19 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SAEZ EVA;RIVAS RODRIGUEZ MARIA;CAMBRONERO AGUDO LORENA;FERNANDEZSANZ ANA BELEN. Datos registrales. T 31745 , F 75, S 8, H M 138130, I/A 57 ( 9.03.18).
01 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MELERO GONZALEZ JOSE ANTONIO;GARCIA NU脩EZ MARIA ELENA;AYUSO LOPEZ EVA MARIA.Apoderado: YANG YANG. Datos registrales. T 31745 , F 74, S 8, H M 138130, I/A 56 (23.11.17).
05 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ BARRAGAN GRACIA;IGLESIAS FLORES BEATRIZ;GARCIA NU脩EZ MARIAELENA;PORTOCARRERO CACERES JORGE LUIS;DIAZ HERRERA AMPARO;MORENO DEL PINO MARIA DE LASMERCEDES;ABRIL GARCIA ESTHER;SANCHEZ TALAVERA VERONICA. Datos registrales. T 31745 , F 74, S 8, H M 138130, I/A55 (28.09.17).
19 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apoderado: MOYANO DE LA IGLESIA PATRICIA;ROMAN BRITO VERONICA ELISABETH. Apo.Sol.: GONZALEZFERNANDEZ LAURA. Apoderado: MU脩OZ MARIA CORAL. Datos registrales. T 31745 , F 73, S 8, H M 138130, I/A 53 (11.09.17).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SANZ ANA BELEN;YANG YANG. Datos registrales. T 31745 , F 73, S 8, H M 138130,I/A 54 (11.09.17).
04 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: DIAZ HERNANDEZ NOEMI. Datos registrales. T 31745 , F 72, S 8, H M 138130, I/A 51 (24.04.17).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MENDOZA SILVIA. Datos registrales. T 31745 , F 72, S 8, H M 138130, I/A 52(24.04.17).
16 de Marzo de 2017Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 45陋 de la Hoja Social, al haberse consignado err贸neamente, en la escritura quemotiv贸 la citada inscripci贸n, que el n煤mero de identificaci贸n fisca de la apoderada era "X5993565A" cuando deb铆a decir "X5993565H".Datos registrales. T 31745 , F 72, S 8, H M 138130, I/A 50 ( 6.03.17).
14 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: CUESTA SANTIAGO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 31745 , F 71, S 8, H M 138130, I/A 49 (7.02.17).
02 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: CANDIA MARTIN-VARES TAMARA. Datos registrales. T 31745 , F 71, S 8, H M 138130, I/A 48(25.01.17).
01 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GARCIA NURIA;MAINEZ ARROJO IRENE. Datos registrales. T 31745 , F 70, S 8, H M138130, I/A 47 (25.01.17).
06 de Septiembre de 2016Reelecciones. Adm. Unico: SUERO VALENZUELA CELESTINO. Datos registrales. T 31745 , F 69, S 8, H M 138130, I/A 44(26.08.16).
Nombramientos. Apoderado: YING AN QI. Datos registrales. T 31745 , F 69, S 8, H M 138130, I/A 45 (26.08.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: ABRIL GARCIA ESTHER;EXPOSITO CANTALEJO JOANA. Datos registrales. T 31745 , F 69, S 8, H M138130, I/A 46 (26.08.16).
29 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: EXPOSITO CANTALEJO JOANA. Datos registrales. T 31745 , F 68, S 8, H M 138130, I/A 43 (18.03.16).
28 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: MORENO SERRANO IMANOL. Datos registrales. T 31745 , F 68, S 8, H M 138130, I/A 42 (15.03.16).
08 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: LARGO DOMINGUEZ ELISA SEGUNDA;MU脩OZ MARIA CORAL. Datos registrales. T 31745 , F 68,S 8, H M 138130, I/A 41 ( 1.02.16).
18 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: CALLEJA DEL OLMO ESTELA;ROSENDO IGLESIAS PATRICIA. Datos registrales. T 31745 , F 67, S 8,H M 138130, I/A 39 (11.12.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ FERNANDEZ LAURA;FERRANDEZ DE MU脩ICO ANA MARIA. Datos registrales. T 31745 ,F 67, S 8, H M 138130, I/A 40 (11.12.15).
23 de Octubre de 2015Cambio de objeto social. Prestaci贸n, por s铆 o a trav茅s de terceros, de los servicios de consultor铆a y asesoramiento dirigido aempresas, profesionales y particulares, en las 谩reas fiscal, laboral, contable, tributario, jur铆dica, inmobiliaria, administraci贸n de fincas,seguros, auditor铆a y comercio exterior...... Datos registrales. T 31745 , F 67, S 8, H M 138130, I/A 38 (15.10.15).
04 de Agosto de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: ALIAGA SAEZ ICIAR. Nombramientos. Apo.Sol.: ABRIL GARCIA ESTHER;BELLO CARDONA ANGELA-MARIA;QUINTANAR FERNANDEZ NURIA. Datos registrales. T 31745 , F 66, S 8, H M 138130, I/A 37 (27.07.15).
03 de Agosto de 2015Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/7. Datos registrales. T 31745 , F 66, S 8, H M 138130, I/A 36(23.07.15).
11 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: GARCIA OBON JAVIER. Apo.Sol.: KOHLER AMOROS GERHARD;ZUBICOA MIQUELEIZ FRANCISCOJAVIER;CARRACEDO NU脩EZ JOSE LUIS;ROMO TIZON MARIA;SANCHEZ TELLO MARIA DEL PILAR. Apoderado: CHUECA YUS
21 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ALIAGA SAEZ ICIAR;RICO GONZALEZ ROCIO;YELA PIZARRO VERONICA. Datos registrales. T31745 , F 66, S 8, H M 138130, I/A 34 (12.05.15).
30 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ARIAS MORAN MARIA EULALIA;CALVO BEITIA ANA. Datos registrales. T 31745 , F 65, S 8, H M138130, I/A 33 (20.10.14).
10 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: CHAPERON SANCHIZ EDUARDO;CABREJAS GILES ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 31745 ,F 65, S 8, H M 138130, I/A 32 ( 3.06.14).
11 de Febrero de 2014Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 31745 ,F 65, S 8, H M 138130, I/A 31 (31.01.14).
23 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: ZARAGOZA GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO. Datos registrales. T 8573 , F 225, S 8, H M138130, I/A 30 (14.01.14).
28 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA BRAVO YAYMA. Datos registrales. T 8573 , F 225, S 8, H M 138130, I/A 29 (18.10.13).
27 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: ROMERO MU脩OZ ARIANA;MARTINEZ RUBIRA MARIA CARMEN;ROMAN BRITO VERONICAELISABETH;TABUENCA LLANAES ROSA MARIA. Datos registrales. T 8573 , F 225, S 8, H M 138130, I/A 28 (18.09.13).
15 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ MILARA JAVIER. Datos registrales. T 8573 , F 225, S 8, H M 138130, I/A 27 ( 5.04.13).
28 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: GARCIA VICARIO EUGENIO JAVIER;MARTIN LARA LUIS. Datos registrales. T 8573 , F 222, S 8, H M138130, I/A 24 (19.06.12).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA VICARIO EUGENIO JAVIER. Datos registrales. T 8573 , F 222, S 8, H M 138130, I/A 25(19.06.12).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN LARA LUIS. Datos registrales. T 8573 , F 224, S 8, H M 138130, I/A 26 (19.06.12).
26 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTIN RIVERA MARIA. Datos registrales. T 8573 , F 222, S 8, H M 138130, I/A 23 (14.03.12).
10 de Febrero de 2012Otros conceptos: RECTIFICADO ERROR PADECIDO EN LA IDENTIDAD DEL APODERADO DON DIEGO TRANCON ELEZ,SIENDO SU PRIMER APELLIDO EL DE TRANCON Y NO EL DE TARANCON. Datos registrales. T 8573 , F 222, S 8, H M 138130,I/A 22 (30.01.12).
20 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: BLANCO ORTEGA DANIEL IGNACIO. Datos registrales. T 8573 , F 222, S 8, H M 138130, I/A 21(30.11.11).
07 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ SANCHEZ JUAN PEDRO;TARANCON ELEZ DIEGO;MARTINEZ GUTIERREZDANIEL;BUENO SANCHO CARLOS. Datos registrales. T 8573 , F 222, S 8, H M 138130, I/A 20 (24.11.11).
17 de Octubre de 2011Reelecciones. Adm. Unico: SUERO VALENZUELA CELESTINO. Datos registrales. T 8573 , F 221, S 8, H M 138130, I/A 19 (3.10.11).
27 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: VILLAVERDE CANO GLORIA;MOYANO DE LA IGLESIA PATRICIA;SANCHEZ BETES ALMUDENA.Datos registrales. T 8573 , F 221, S 8, H M 138130, I/A 18 (12.04.11).
03 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: CHUECA YUS DAVID. Datos registrales. T 8573 , F 221, S 8, H M 138130, I/A 17 (19.02.10).
03 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 359.999,00 Euros. Desembolsado: 359.999,00 Euros. Resultante Suscrito: 540.299,00 Euros.Resultante Desembolsado: 540.299,00 Euros. Datos registrales. T 8573 , F 220, S 8, H M 138130, I/A 16 (17.08.09).
22 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: ROMO TIZON MARIA;MARTOS LOPEZ GEMMA ISABEL;SANCHEZ TELLO MARIA DEL PILAR;DIAZGUTIERREZ CARLOS;MELERO GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 8573 , F 220, S 8, H M 138130, I/A 15 ( 9.07.09).
13 de Enero de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: MELERO GONZALEZ JOSE ANTONIO;GARCIA NU脩EZ MARIA ELENA;AYUSO LOPEZ EVA MARIA.Datos registrales. T 8573 , F 220, S 8, H M 138130, I/A 14 (30.12.08).