Actos BORME de Consultoria Guasch Sl
22 de Octubre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 63.109,20 Euros. Resultante Suscrito: 172.498,48 Euros. Datos registrales. T 40211 , F 24, S 8, H B35682, I/A 21 (11.10.21).
27 de Mayo de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.202,08 Euros. Resultante Suscrito: 109.389,28 Euros. Datos registrales. T 40211 , F 24, S 8, H B35682, I/A 20 (17.05.19).
15 de Noviembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 27.046,80 Euros. Resultante Suscrito: 108.187,20 Euros. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DEL ARTICULO 16 .- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. Cambio de domicilio social. AV CAMI DELSCAPELLANS, 71 BAJOS (SITGES). Cambio de objeto social. SE AMPLIA A: GESTION DE ACTIVIDADES TURISTICAS. Fusi贸npor absorci贸n. Sociedades absorbidas: FUENTECEN SL. Datos registrales. T 29786 , F 9, S 8, H B 35682, I/A 19 ( 6.11.17).
27 de Abril de 2016Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: HUGUET GUASCH JOSEP. Datos registrales. T 29786 , F 9, S 8, H B 35682, I/A 18 (19.04.16).
14 de Enero de 2013Modificaciones estatutarias. ART.16:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 29786, F 8, S 8, H B 35682, I/A 17 ( 7.01.13).
05 de Diciembre de 2011Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: HUGUET TORREMADE JOSE MARIA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: HUGUET GUASCHGEMMA. Cambio de objeto social. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTOECONOMICO,FISCAL,JURIDICO,DE MARKETING Y DE TODO LO RELACIONADO CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.LATENENCIA,TRANSMISION,PROMOCION,ADMINISTRACION Y GESTION DE BIENES... Datos registrales. T 29786 , F 8, S 8, H B35682, I/A 16 (23.11.11).