Actos BORME de Contenosa Sa
14 de Noviembre de 2023Otros conceptos: EMISION DEL TITULO MULTIPLE NUMERO 1 REPRESENTATIVO DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIALDE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 47775 , F 141, S 8, H B 34310, I/A 80 N ( 6.11.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: PAZOS CARBALLAL DAVID. Datos registrales. T 48799 , F 177, S 8, H B 34310, I/A 89(27.07.23).
Nombramientos. APOD.MANCOMU: RODRIGUEZ LORENZO JOSE LUIS. Datos registrales. T 48799 , F 177, S 8, H B 34310, I/A90 (27.07.23).
17 de Julio de 2023Revocaciones. CONSEJERO: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. CONS.DEL.SOL: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL.VICEPRESIDEN: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. Nombramientos. CONSEJERO: MARTINEZ AYUSO CARLOS.CONS.DEL.SOL: MARTINEZ AYUSO CARLOS. VICEPRESIDEN: MARTINEZ AYUSO CARLOS. Datos registrales. T 48799 , F 176,S 8, H B 34310, I/A 88 (10.07.23).
13 de Junio de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: PAZOS CARBALLAL DAVID;GARCIA GOMEZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 47775 ,F 149, S 8, H B 34310, I/A 87 ( 6.06.23).
20 de Enero de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CONTENOSA CANARIAS SA. Datos registrales. T 47775 , F 146, S 8, H B 34310,I/A 86 (13.01.23).
19 de Agosto de 2022Revocaciones. SECR.NO CONS: DONADEU GARCIA NIETO GUILLERMO. Nombramientos. SECR.NO CONS: GARCIA GOMEZMARIA VICTORIA. VICEPRESIDEN: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. Datos registrales. T 47775 , F 146, S 8, H B 34310, I/A 85(11.08.22).
27 de Julio de 2022Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: SCAN GLOBAL LOGISTICS SPAIN SL. Datos registrales. T 47775 , F143, S 8, H B 34310, I/A 84 (19.07.22).
13 de Diciembre de 2021Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 47775 , F 143, S 8, H B 34310, I/A 83 ( 2.12.21).
26 de Julio de 2021Fe de erratas: En el BORME no.207/2012 y con referencia 437458 SE OMITIO LA REVOCACION DE LOS APODERADO ENRIQUEPIEDRA GOMEZ y AGUSTIN RUBIO ROSELL, NOMBRADOS EN LAS INSCRIPCIONES 22 Y 36, RESPECTIVAMENTE. Datosregistrales. T 33059 , F 107, S 8, H B 34310, I/A 69 (16.10.12).
23 de Julio de 2021Revocaciones. APODERADO: MONCLUS LLORT MANUEL. APOD.MANCOMU: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A;TEJEROCORNEJO JULIAN;PEREZ CATALINA YOLANDA. Datos registrales. T 47775 , F 143, S 8, H B 34310, I/A 82 (15.07.21).
10 de Junio de 2021Revocaciones. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Nombramientos. CONSEJERO: CLAES BROENSGAARD PEDERSEN.PRESIDENTE: CLAES BROENSGAARD PEDERSEN. CONSEJERO: ALLAN DYRGAARD MELGAARD;OUJO IZCUE RAIMUNDO
20 de Mayo de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.032.670,04 Euros. Resultante Suscrito: 765.565,82 Euros. Datos registrales. T 47775 ,F 141, S 8, H B 34310, I/A 80 (12.05.21).
27 de Diciembre de 2018Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 110, S 8, H B 34310, I/A 79 (18.12.18).
05 de Septiembre de 2018Nombramientos. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Datos registrales. T 33059 , F 110, S 8, H B 34310, I/A 77 (29.08.18).
Revocaciones. APODERADO: MARTIN RODRIGUEZ SUSANA. Datos registrales. T 33059 , F 110, S 8, H B 34310, I/A 78(29.08.18).
27 de Junio de 2018Nombramientos. APOD.MANCOMU: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A;TEJERO CORNEJO JULIAN;PEREZ CATALINA YOLANDA.Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 76 (18.06.18).
30 de Noviembre de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 75 (23.11.17).
26 de Noviembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 74 (18.11.14).
05 de Noviembre de 2013Nombramientos. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 73 (25.10.13).
16 de Octubre de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 108, S 8, H B 34310, I/A 72 ( 8.10.13).
15 de Julio de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 320.272,90 Euros. Desembolsado: 320.272,90 Euros. Resultante Suscrito: 3.798.235,86 Euros.Resultante Desembolsado: 3.798.235,86 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 108, S 8, H B 34310, I/A 71 ( 8.07.13).
26 de Diciembre de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 108, S 8, H B 34310, I/A 70 (18.12.12).
26 de Octubre de 2012Revocaciones. APODERADO: DIAZ GONZALEZ RAMON ESTANISLAO;RODRIGUEZ ROIJALS OSCAR;ARIAS SANTANDREUMAURICIO;MU脩OZ GONZALEZ FERNANDO;RUBIO ROSELL AGUSTIN;PIEDRA GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 33059 ,F 107, S 8, H B 34310, I/A 69 (16.10.12).
28 de Diciembre de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 107, S 8, H B 34310, I/A 68 (19.12.11).
13 de Junio de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 414.822,22 Euros. Desembolsado: 414.822,22 Euros. Resultante Suscrito: 3.477.962,96 Euros.Resultante Desembolsado: 3.477.962,96 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 106, S 8, H B 34310, I/A 67 ( 2.06.11).
31 de Enero de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 106, S 8, H B 34310, I/A 66 (19.01.11).
29 de Abril de 2010Nombramientos. APODERADO: MARTIN RODRIGUEZ SUSANA. Datos registrales. T 33059 , F 105, S 8, H B 34310, I/A 65(20.04.10).
Nombramientos. APODERADO: MONCLUS LLORT MANUEL. Datos registrales. T 33059 , F 104, S 8, H B 34310, I/A 64(20.04.10).
15 de Abril de 2010Nombramientos. APODERADO: PALOS GA脩AN ISIDRO;VILLAHERMOSA SANCHEZ ALFONSO;ARIAS SANTANDREUMAURICIO. Datos registrales. T 33059 , F 104, S 8, H B 34310, I/A 62 (31.03.10).
Revocaciones. APODERADO: MARTIN RODRIGUEZ SUSANA;DIAZ GONZALEZ RAMON ESTANISLAO. Datos registrales. T33059 , F 104, S 8, H B 34310, I/A 63 (31.03.10).
09 de Diciembre de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 103, S 8, H B 34310, I/A 61 (26.11.09).
23 de Noviembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 901.500,00 Euros. Desembolsado: 901.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.063.140,74 Euros.Resultante Desembolsado: 3.063.140,74 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 102, S 8, H B 34310, I/A 60 (10.11.09).
28 de Octubre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 358.640,74 Euros. Desembolsado: 358.640,74 Euros. Resultante Suscrito: 2.161.640,74 Euros.Resultante Desembolsado: 2.161.640,74 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 101, S 8, H B 34310, I/A 59 (16.10.09).
12 de Enero de 2009Revocaciones. CONSEJERO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. PRESIDENTE: RUBIO ROSELL AGUSTIN. CONS. DELEG.: RUBIOROSELL AGUSTIN. CONSEJERO: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A. SECRETARIO: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A.CONSEJERO: RUBIO ROSELL NURIA. Nombramientos. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Modificaciones estatutarias.ARTS. 4,9,14,16,19,23 Y 26 A 37: CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 33059 , F 99, S 8, H B 34310, I/A58 (24.12.08).