Buscador CIF Logo

Actos BORME Contenosa Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Contenosa Sa

Actos BORME Contenosa Sa - A28517274

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Contenosa Sa con CIF A28517274

馃敊 Perfil de Contenosa Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Contenosa Sa

14 de Noviembre de 2023
Otros conceptos: EMISION DEL TITULO MULTIPLE NUMERO 1 REPRESENTATIVO DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIALDE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 47775 , F 141, S 8, H B 34310, I/A 80 N ( 6.11.23).

04 de Agosto de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: PAZOS CARBALLAL DAVID. Datos registrales. T 48799 , F 177, S 8, H B 34310, I/A 89(27.07.23).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: RODRIGUEZ LORENZO JOSE LUIS. Datos registrales. T 48799 , F 177, S 8, H B 34310, I/A90 (27.07.23).

17 de Julio de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. CONS.DEL.SOL: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL.VICEPRESIDEN: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. Nombramientos. CONSEJERO: MARTINEZ AYUSO CARLOS.CONS.DEL.SOL: MARTINEZ AYUSO CARLOS. VICEPRESIDEN: MARTINEZ AYUSO CARLOS. Datos registrales. T 48799 , F 176,S 8, H B 34310, I/A 88 (10.07.23).

13 de Junio de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: PAZOS CARBALLAL DAVID;GARCIA GOMEZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 47775 ,F 149, S 8, H B 34310, I/A 87 ( 6.06.23).

20 de Enero de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CONTENOSA CANARIAS SA. Datos registrales. T 47775 , F 146, S 8, H B 34310,I/A 86 (13.01.23).

19 de Agosto de 2022
Revocaciones. SECR.NO CONS: DONADEU GARCIA NIETO GUILLERMO. Nombramientos. SECR.NO CONS: GARCIA GOMEZMARIA VICTORIA. VICEPRESIDEN: OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. Datos registrales. T 47775 , F 146, S 8, H B 34310, I/A 85(11.08.22).

27 de Julio de 2022
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: SCAN GLOBAL LOGISTICS SPAIN SL. Datos registrales. T 47775 , F143, S 8, H B 34310, I/A 84 (19.07.22).

13 de Diciembre de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 47775 , F 143, S 8, H B 34310, I/A 83 ( 2.12.21).

26 de Julio de 2021
Fe de erratas: En el BORME no.207/2012 y con referencia 437458 SE OMITIO LA REVOCACION DE LOS APODERADO ENRIQUEPIEDRA GOMEZ y AGUSTIN RUBIO ROSELL, NOMBRADOS EN LAS INSCRIPCIONES 22 Y 36, RESPECTIVAMENTE. Datosregistrales. T 33059 , F 107, S 8, H B 34310, I/A 69 (16.10.12).

23 de Julio de 2021
Revocaciones. APODERADO: MONCLUS LLORT MANUEL. APOD.MANCOMU: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A;TEJEROCORNEJO JULIAN;PEREZ CATALINA YOLANDA. Datos registrales. T 47775 , F 143, S 8, H B 34310, I/A 82 (15.07.21).

10 de Junio de 2021
Revocaciones. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Nombramientos. CONSEJERO: CLAES BROENSGAARD PEDERSEN.PRESIDENTE: CLAES BROENSGAARD PEDERSEN. CONSEJERO: ALLAN DYRGAARD MELGAARD;OUJO IZCUE RAIMUNDO

20 de Mayo de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.032.670,04 Euros. Resultante Suscrito: 765.565,82 Euros. Datos registrales. T 47775 ,F 141, S 8, H B 34310, I/A 80 (12.05.21).

27 de Diciembre de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 110, S 8, H B 34310, I/A 79 (18.12.18).

05 de Septiembre de 2018
Nombramientos. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Datos registrales. T 33059 , F 110, S 8, H B 34310, I/A 77 (29.08.18).

Revocaciones. APODERADO: MARTIN RODRIGUEZ SUSANA. Datos registrales. T 33059 , F 110, S 8, H B 34310, I/A 78(29.08.18).

27 de Junio de 2018
Nombramientos. APOD.MANCOMU: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A;TEJERO CORNEJO JULIAN;PEREZ CATALINA YOLANDA.Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 76 (18.06.18).

30 de Noviembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 75 (23.11.17).

26 de Noviembre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 74 (18.11.14).

05 de Noviembre de 2013
Nombramientos. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Datos registrales. T 33059 , F 109, S 8, H B 34310, I/A 73 (25.10.13).

16 de Octubre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 108, S 8, H B 34310, I/A 72 ( 8.10.13).

15 de Julio de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 320.272,90 Euros. Desembolsado: 320.272,90 Euros. Resultante Suscrito: 3.798.235,86 Euros.Resultante Desembolsado: 3.798.235,86 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 108, S 8, H B 34310, I/A 71 ( 8.07.13).

26 de Diciembre de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 108, S 8, H B 34310, I/A 70 (18.12.12).

26 de Octubre de 2012
Revocaciones. APODERADO: DIAZ GONZALEZ RAMON ESTANISLAO;RODRIGUEZ ROIJALS OSCAR;ARIAS SANTANDREUMAURICIO;MU脩OZ GONZALEZ FERNANDO;RUBIO ROSELL AGUSTIN;PIEDRA GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 33059 ,F 107, S 8, H B 34310, I/A 69 (16.10.12).

28 de Diciembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 107, S 8, H B 34310, I/A 68 (19.12.11).

13 de Junio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 414.822,22 Euros. Desembolsado: 414.822,22 Euros. Resultante Suscrito: 3.477.962,96 Euros.Resultante Desembolsado: 3.477.962,96 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 106, S 8, H B 34310, I/A 67 ( 2.06.11).

31 de Enero de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 106, S 8, H B 34310, I/A 66 (19.01.11).

29 de Abril de 2010
Nombramientos. APODERADO: MARTIN RODRIGUEZ SUSANA. Datos registrales. T 33059 , F 105, S 8, H B 34310, I/A 65(20.04.10).

Nombramientos. APODERADO: MONCLUS LLORT MANUEL. Datos registrales. T 33059 , F 104, S 8, H B 34310, I/A 64(20.04.10).

15 de Abril de 2010
Nombramientos. APODERADO: PALOS GA脩AN ISIDRO;VILLAHERMOSA SANCHEZ ALFONSO;ARIAS SANTANDREUMAURICIO. Datos registrales. T 33059 , F 104, S 8, H B 34310, I/A 62 (31.03.10).

Revocaciones. APODERADO: MARTIN RODRIGUEZ SUSANA;DIAZ GONZALEZ RAMON ESTANISLAO. Datos registrales. T33059 , F 104, S 8, H B 34310, I/A 63 (31.03.10).

09 de Diciembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ALTER BG AUDITORS SL. Datos registrales. T 33059 , F 103, S 8, H B 34310, I/A 61 (26.11.09).

23 de Noviembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 901.500,00 Euros. Desembolsado: 901.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.063.140,74 Euros.Resultante Desembolsado: 3.063.140,74 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 102, S 8, H B 34310, I/A 60 (10.11.09).

28 de Octubre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 358.640,74 Euros. Desembolsado: 358.640,74 Euros. Resultante Suscrito: 2.161.640,74 Euros.Resultante Desembolsado: 2.161.640,74 Euros. Datos registrales. T 33059 , F 101, S 8, H B 34310, I/A 59 (16.10.09).

12 de Enero de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. PRESIDENTE: RUBIO ROSELL AGUSTIN. CONS. DELEG.: RUBIOROSELL AGUSTIN. CONSEJERO: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A. SECRETARIO: RUBIO ROSELL MARIA BEGO脩A.CONSEJERO: RUBIO ROSELL NURIA. Nombramientos. ADM.UNICO: RUBIO ROSELL AGUSTIN. Modificaciones estatutarias.ARTS. 4,9,14,16,19,23 Y 26 A 37: CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 33059 , F 99, S 8, H B 34310, I/A58 (24.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n