Actos BORME de Contourglobal Termosolar Sl
21 de Diciembre de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35062 , F 43, S 8, H M 630571, I/A 20 (14.12.23).
04 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ALCORLO GONZALEZ MARTA. Revocaciones. Apo.Manc.: ALCORLO GONZALEZ MARTA.Apoderado: ALCORLO GONZALEZ MARTA. Nombramientos. Adm. Mancom.: MORO MEGIAS FELIX. Apoderado: MORO MEGIASFELIX. Datos registrales. T 35062 , F 42, S 8, H M 630571, I/A 18 (28.07.23).
Nombramientos. Apoderado: MORO MEGIAS FELIX. Datos registrales. T 35062 , F 43, S 8, H M 630571, I/A 19 (28.07.23).
23 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: MATAIX PEREZ JORGE. Datos registrales. T 35062 , F 42, S 8, H M 630571, I/A 17 (15.03.23).
17 de Marzo de 2023Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 34, PLANTA 1ª (MADRID). Datos registrales. T 35062 , F 41, S 8, H M 630571, I/A 16(10.03.23).
16 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DIAZ BARRIO GABRIEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARTINEZ GARCIA FRANCISCOJAVIER. Apoderado: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 35062 , F 41, S 8, H M 630571, I/A 15 (9.03.23).
07 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MINGUEZ MARTIN NORBERTO;MATAIX PEREZ JORGE;ALCORLO GONZALEZ MARTA;MARTINEZGARCIA FRANCISCO JAVIER;PEÑACOBA RIVAS EDUARDO;CASTRO FERNANDEZ CECILIA;TORRES COLMENARESCARMEN;GIMENO MORAN JESUS;ZALDIVAR DE LA RICA ALVARO;BORDA GUERRA ITZIAR;CALVENTE MENENDEZJUAN;PORTELA PONTE PAULO. Datos registrales. T 35062 , F 39, S 8, H M 630571, I/A 14 (29.11.22).
05 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35062 , F 39, S 8, H M 630571, I/A13 (28.11.22).
21 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35062 , F 39, S 8, H M 630571, I/A12 (14.12.21).
27 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: PORTANET JAVIER. Datos registrales. T 35062 , F 39, S 8, H M 630571, I/A 11 (20.05.19).
15 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35062 , F 38, S 8, H M 630571,I/A 10 ( 8.01.19).
27 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: JUILLARD BOUDET JEAN CHRISTOPHE. Nombramientos. Adm. Mancom.: ALCORLOGONZALEZ MARTA. Datos registrales. T 35062 , F 38, S 8, H M 630571, I/A 9 (19.11.18).
01 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: GESTION DE RECURSOS CORPORATIVOS SL. Datos registrales. T 35062 , F 38, S 8, H M 630571,I/A 8 (24.05.18).
28 de Mayo de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CONTOURGLOBAL MIRROR 2 S.A R.L. Datos registrales. T35062 , F 37, S 8, H M 630571, I/A 6 (17.05.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: HIMPE MAARTEN ERIC G.;COMBE JULIEN;HULLO LAURENT GERMAIN;ALCORLO GONZALEZMARTA;PORTANET JAVIER. Datos registrales. T 35062 , F 37, S 8, H M 630571, I/A 7 (21.05.18).