Actos BORME de Cookie Box Sl
12 de Septiembre de 2022Cambio de domicilio social. CL RAMBLA CATALUNYA Num.38 P.6 (BARCELONA). Datos registrales. T 41029 , F 128, S 8, H B375359, I/A 20 (18.08.22).
16 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.986,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.929,00 Euros. Datos registrales. T 36794 , F 217, S 8, H M658966, I/A 4 ( 5.12.19).
17 de Mayo de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.988,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.943,00 Euros. Datos registrales. T 36794 , F 217, S 8, H M658966, I/A 3 ( 8.05.18).
22 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ O'DONNEL 12 - PLANTA 3陋 (MADRID). Datos registrales. T 36794 , F 217, S 8, H M 658966, I/A 2(15.12.17).
12 de Abril de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.475,00 Euros. Resultante Suscrito: 15.955,00 Euros. Datos registrales. T 41029 , F 126,S 8, H B 375359, I/A 16 ( 4.04.17).
18 de Octubre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 11.620,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.430,00 Euros. Datos registrales. T 41029 , F 125, S 8, H B375359, I/A 15 ( 7.10.16).
17 de Noviembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: RUPERTI SALVANY BUENAVENTURA;CORBETO GALL SERGIO. PRESIDENTE: CORBETO GALLSERGIO. CONSEJERO: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS. SECR.NO CONS: LAMARCA FLINCH TOMAS. CONS. DELEG.:ANDREU BUSTAMANTE CARLOS. Nombramientos. ADM.UNICO: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS. Datos registrales. T 41029, F 125, S 8, H B 375359, I/A 13 ( 9.11.15).
Revocaciones. APODERADO: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS;CORBETO GALL SERGIO. Datos registrales. T 41029 , F 125,S 8, H B 375359, I/A 14 ( 9.11.15).
22 de Mayo de 2015Cambio de domicilio social. CL ROCAFORT,116-120 P.EN PTA.8 (BARCELONA). Datos registrales. T 41029 , F 125, S 8, H B375359, I/A 12 (15.05.15).
02 de Marzo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.802,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.810,00 Euros. Datos registrales. T 40796 , F 98, S 8, H B375359, I/A 11 (20.02.15).
28 de Octubre de 2014Nombramientos. CONS. DELEG.: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS. Datos registrales. T 40796 , F 98, S 8, H B 375359, I/A 10(21.10.14).
20 de Marzo de 2014Revocaciones. APODERADO: ORTU脩O ROMAGOSA JAVIER. Datos registrales. T 40796 , F 97, S 8, H B 375359, I/A 8(13.03.14).
Revocaciones. CONSEJERO: ORTU脩O ROMAGOSA JAVIER. Nombramientos. CONSEJERO: RUPERTI SALVANYBUENAVENTURA. Datos registrales. T 40796 , F 98, S 8, H B 375359, I/A 9 (13.03.14).
29 de Noviembre de 2013Revocaciones. CONSEJERO: MONFORT VILLARROYA NORBERT. Datos registrales. T 40796 , F 97, S 8, H B 375359, I/A 5(21.11.13).
Revocaciones. APODERADO: MONFORT VILLARROYA NORBERT. Datos registrales. T 40796 , F 97, S 8, H B 375359, I/A 6(21.11.13).
Nombramientos. CONSEJERO: RUPERTI SALVANY BUENAVENTURA. Datos registrales. T 40796 , F 97, S 8, H B 375359, I/A 7(21.11.13).
24 de Abril de 2013Cambio de objeto social. DISE脩AR Y DESPLEGAR PROYECTOS DE COMUNICACION INTERNA A FIN DE ASEGURARLAEFECTIVIDAD DE LOS MENSAJES QUE FLUYEN DEL DIRECTIVO AL COLABORADOR.ASESORAMIENTO Y CONSULTORIAEN MATERIA LABORAL,RECURSOS HUMANOS... Datos registrales. T 40796 , F 97, S 8, H B 375359, I/A 4 (15.04.13).
05 de Abril de 2013Revocaciones. APODERADO: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS;ORTU脩O ROMAGOSA JAVIER;CORBETO GALLSERGIO;MONFORT VILLARROYA NORBERT. Nombramientos. APODERADO: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS;ORTU脩OROMAGOSA JAVIER;CORBETO GALL SERGIO;MONFORT VILLARROYA NORBERT. Datos registrales. T 40796 , F 95, S 8, H B375359, I/A 3 (25.03.13).
23 de Enero de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: CORBETO GALL SERGIO. Nombramientos. CONSEJERO: CORBETO GALL SERGIO.PRESIDENTE: CORBETO GALL SERGIO. CONSEJERO: ANDREU BUSTAMANTE CARLOS;MONFORT VILLARROYANORBERT;ORTU脩O ROMAGOSA JAVIER. SECR.NO CONS: LAMARCA FLINCH TOMAS. APODERADO: ANDREU BUSTAMANTECARLOS;ORTU脩O ROMAGOSA JAVIER;CORBETO GALL SERGIO;MONFORT VILLAROYA NORBERT. Datos registrales. T40796 , F 94, S 8, H B 375359, I/A 2 (16.01.13).