Buscador CIF Logo

Actos BORME Cooper-standard Automotive España Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cooper-standard Automotive España Sl

Actos BORME Cooper-standard Automotive España Sl - B28125185

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Cooper-standard Automotive España Sl con CIF B28125185

🔙 Perfil de Cooper-standard Automotive España Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Cooper-standard Automotive España Sl

30 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: CAMPBELL ALLEN J. Datos registrales. T 4089 , F 200, S 8, H Z 57923, I/A 33 (23.12.21).

Revocaciones. Apoderado: BRETON RUIZ JOSE EMILIO. Datos registrales. T 4089 , F 200, S 8, H Z 57923, I/A 34 (23.12.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: PENNANECH LUDOVIC FRANCOIS. Datos registrales. T 4089 , F 200, S 8, H Z 57923, I/A 35(23.12.21).

27 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 4089 , F 200, S 8, H Z 57923, I/A 32 (21.12.21).

29 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO. Presidente: GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO.Nombramientos. Consejero: PENNANECH LUDOVIC FRANCOIS. Presidente: ESPARZA HERRAIZ JAVIER. Datos registrales. T4089 , F 197, S 8, H Z 57923, I/A 28 (25.10.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: SMIT E/V BAVELAAR HENDRIKA THERESIA MARIA. Datos registrales. T 4089 , F 197, S 8, H Z 57923,I/A 29 (25.10.21).

Nombramientos. Apo.Manc.: AJAMIL VIANA EDUARDO J.;SANCHEZ PEREZ JESUS. Datos registrales. T 4089 , F 197, S 8, H Z57923, I/A 30 (25.10.21).

Nombramientos. Apoderado: SEBASTIAN ALASTRUE SERGIO. Datos registrales. T 4089 , F 199, S 8, H Z 57923, I/A 31(25.10.21).

21 de Julio de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VAN DEN BERG MAARTEN D G. Apo.Sol.: VAN DEN BERG MAARTEN D G. Apo.Manc.: VAN DEBERG MAARTEN;GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO. Apoderado: GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO. Apo.Manc.: GASPARHERNANDEZ FRANCISCO;VAN DEN BERG MAARTEN DIEDERIK GASTON;BAVELAAR MARIA. Datos registrales. T 4089 , F 196,S 8, H Z 57923, I/A 27 (14.07.21).

23 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPARZA HERRAIZ JAVIER. Datos registrales. T 4089 , F 194, S 8, H Z 57923, I/A 25 (16.06.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: SMIT E/V BAVELAAR HENDRIKA THERESIA MARIA. Datos registrales. T 4089 , F 195, S 8, H Z57923, I/A 26 (16.06.21).

28 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: HELMRICH HANS OSKAR. Nombramientos. Consejero: SEBASTIAN ALASTRUE SERGIO. Datosregistrales. T 4089 , F 194, S 8, H Z 57923, I/A 24 (21.05.21).

12 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4089 , F 192, S 8, H Z 57923, I/A 23 (5.02.21).

06 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO. Presidente: DE MIGUEL POSADA JUAN FERNANDO.Consejero: DE MIGUEL POSADA JUAN FERNANDO. Nombramientos. Consejero: ESPARZA HERRAIZ JAVIER. Presidente:GASPAR HERNANDEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4089 , F 191, S 8, H Z 57923, I/A 17 (30.07.20).

Cambio de domicilio social. C/ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA S/N - POLIGONO INDUS (TARAZONA). Datos registrales. T4089 , F 191, S 8, H Z 57923, I/A 18 (30.07.20).

Revocaciones. Apoderado: ASIN SOFIN JOSE-EDUARDO. Datos registrales. T 4089 , F 191, S 8, H Z 57923, I/A 19 (30.07.20).

Revocaciones. Apo.Manc.: DE MIGUEL POSADA JUAN FERNANDO;DE MIGUEL POSADA JUAN FERNANDO. Datos registrales.T 4089 , F 191, S 8, H Z 57923, I/A 20 (30.07.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información