Buscador CIF Logo

Actos BORME Copcisa Promo Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Copcisa Promo Sl

Actos BORME Copcisa Promo Sl - B63188692

Tenemos registrados 44 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Copcisa Promo Sl con CIF B63188692

馃敊 Perfil de Copcisa Promo Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Copcisa Promo Sl

02 de Agosto de 2019
Revocaciones. APODERAD.SOL: GOMEZ CABRERA NAYLA. Datos registrales. T 44284 , F 189, S 8, H B 265789, I/A 60(25.07.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: PUIG ROIG MIQUEL. Datos registrales. T 44284 , F 189, S 8, H B 265789, I/A 61 (25.07.19).

20 de Febrero de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 44284 ,F 188, S 8, H B 265789, I/A 59 (12.02.19).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 188, S 8, H B 265789, I/A 58 (20.11.18).

14 de Diciembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 188, S 8, H B 265789, I/A 57 (30.11.17).

15 de Noviembre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: JOVAL PALACIN ANNA;FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT;GOMEZ CABRERANAYLA;GRANADOS PEREZ ICIAR;ARCONADA PUERTAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 44284 , F 187, S 8, H B 265789, I/A 56( 6.11.17).

04 de Julio de 2017
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ARROYO LUCENA ANA MARIA. Datos registrales. T 44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 55(26.06.17).

30 de Diciembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 54 (21.12.16).

29 de Julio de 2016
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ SANTA CRUZ BENITO. Datos registrales. T44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 53 (20.07.16).

03 de Febrero de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 52 (27.01.16).

29 de Abril de 2015
Revocaciones. ADM.UNICO: COPCISA CORP SL. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA ELOI. Nombramientos.ADM.UNICO: COPCISA CORP SL. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA ELOI. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B265789, I/A 51 (21.04.15).

03 de Febrero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 50 (26.01.15).

12 de Diciembre de 2014
Revocaciones. APODERADO: CARBONELL SANTACANA RAMON. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 49 (3.12.14).

20 de Noviembre de 2014
Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA RAMON. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELLSANTACANA ELOI. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 48 (13.11.14).

10 de Octubre de 2014
Modificaciones estatutarias. ART.24: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 47 ( 3.10.14).

04 de Agosto de 2014
Revocaciones. APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA. Datos registrales. T 44284, F 183, S 8, H B 265789, I/A 46 (25.07.14).

24 de Abril de 2014
Revocaciones. APODERADO: BADRENAS JUNYENT JOSE;CASAJUANA MIRAS ALBERT;SANCHEZ RUIZ ANTONIO. Datosregistrales. T 39032 , F 225, S 8, H B 265789, I/A 43 (15.04.14).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GALOPA VILARET JOSEP MARIA;MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ SANTACRUZ BENITO Datos registrales. T 39032 , F 225, S 8, H B 265789, I/A 44 (15.04.14).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CULLELL VILARO MARC. Datos registrales. T 44284 , F 182, S 8, H B 265789, I/A 45(15.04.14).

26 de Febrero de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 158.120.419,00 Euros. Resultante Suscrito: 700.000,00 Euros. Datos registrales. T 39032, F 225, S 8, H B 265789, I/A 42 (17.02.14).

03 de Enero de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 224, S 8, H B 265789, I/A 40 (24.12.13).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 225, S 8, H B 265789, I/A 41 (24.12.13).

31 de Enero de 2013
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 224, S 8, H B 265789, I/A 38 (23.01.13).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 224, S 8, H B 265789, I/A 39 (23.01.13).

02 de Febrero de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 36 (24.01.12).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 37 (24.01.12).

02 de Enero de 2012
Otros conceptos: RECTIFICADO EL DNI DEL APODERADO DON JUAN MANUEL MARQUEZ GOMEZ. Datos registrales. T39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 35 (20.12.11).

06 de Mayo de 2011
Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCET BENET. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANARAMON. Datos registrales. T 39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 34 (20.04.11).

24 de Enero de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 222, S 8, H B 265789, I/A 32 (12.01.11).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 222, S 8, H B 265789, I/A 33 (12.01.11).

12 de Enero de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FORAT 19 SL. COPCISA CAPITAL SL. Datos registrales. T 39032 , F 219, S 8, H B265789, I/A 31 (29.12.10).

22 de Noviembre de 2010
Revocaciones. APODERADO: BELLAFONT ALVARO LUIS. Datos registrales. T 39032 , F 219, S 8, H B 265789, I/A 30 ( 5.11.10).

11 de Noviembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.207.527,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.820.419,00 Euros. Datos registrales. T 39032 , F217, S 8, H B 265789, I/A 29 (28.10.10).

02 de Noviembre de 2010
Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 39032 , F 215, S 8, H B 265789, I/A 28(20.10.10).

13 de Julio de 2010
Revocaciones. APODERADO: LLENA NICOLAU JUAN CARLOS. Datos registrales. T 39032 , F 215, S 8, H B 265789, I/A 27 (1.07.10).

24 de Junio de 2010
Nombramientos. APODERADO: CASAJUANA MIRAS ALBERT. Datos registrales. T 39032 , F 212, S 8, H B 265789, I/A 26(11.06.10).

16 de Marzo de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 211, S 8, H B 265789, I/A 24 ( 3.03.10).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 212, S 8, H B 265789, I/A 25 ( 3.03.10).

10 de Marzo de 2010
Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL TARRES JOSEP. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCETBENET. Datos registrales. T 39032 , F 211, S 8, H B 265789, I/A 23 (24.02.10).

08 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 717.676,00 Euros. Resultante Suscrito: 130.612.892,00 Euros. Datos registrales. T 39032 , F 210, S8, H B 265789, I/A 22 (26.01.10).

24 de Diciembre de 2009
Nombramientos. APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA. Datos registrales. T39032 , F 208, S 8, H B 265789, I/A 21 (15.12.09).

05 de Octubre de 2009
Revocaciones. APODERADO: PALOUZIE SARRAT JOSE FELIX. Datos registrales. T 39032 , F 208, S 8, H B 265789, I/A 20(22.09.09).

09 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.647.414,00 Euros. Resultante Suscrito: 129.895.216,00 Euros. Datos registrales. T 39032 , F 207,S 8, H B 265789, I/A 19 (28.08.09).

25 de Junio de 2009
Revocaciones. APODERADO: HUGO PUGLISI. Datos registrales. T 39032 , F 207, S 8, H B 265789, I/A 18 (15.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n