Actos BORME de Copcisa Promo Sl
02 de Agosto de 2019Revocaciones. APODERAD.SOL: GOMEZ CABRERA NAYLA. Datos registrales. T 44284 , F 189, S 8, H B 265789, I/A 60(25.07.19).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PUIG ROIG MIQUEL. Datos registrales. T 44284 , F 189, S 8, H B 265789, I/A 61 (25.07.19).
20 de Febrero de 2019Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 44284 ,F 188, S 8, H B 265789, I/A 59 (12.02.19).
28 de Noviembre de 2018Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 188, S 8, H B 265789, I/A 58 (20.11.18).
14 de Diciembre de 2017Nombramientos. AUDIT.INDIV.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 188, S 8, H B 265789, I/A 57 (30.11.17).
15 de Noviembre de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: JOVAL PALACIN ANNA;FERNANDEZ VALVERDE MONTSERRAT;GOMEZ CABRERANAYLA;GRANADOS PEREZ ICIAR;ARCONADA PUERTAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 44284 , F 187, S 8, H B 265789, I/A 56( 6.11.17).
04 de Julio de 2017Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ARROYO LUCENA ANA MARIA. Datos registrales. T 44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 55(26.06.17).
30 de Diciembre de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 54 (21.12.16).
29 de Julio de 2016Revocaciones. APOD.SOL/MAN: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ SANTA CRUZ BENITO. Datos registrales. T44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 53 (20.07.16).
03 de Febrero de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 185, S 8, H B 265789, I/A 52 (27.01.16).
29 de Abril de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: COPCISA CORP SL. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA ELOI. Nombramientos.ADM.UNICO: COPCISA CORP SL. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA ELOI. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B265789, I/A 51 (21.04.15).
03 de Febrero de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 50 (26.01.15).
12 de Diciembre de 2014Revocaciones. APODERADO: CARBONELL SANTACANA RAMON. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 49 (3.12.14).
20 de Noviembre de 2014Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANA RAMON. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELLSANTACANA ELOI. Datos registrales. T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 48 (13.11.14).
10 de Octubre de 2014Modificaciones estatutarias. ART.24: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 44284 , F 184, S 8, H B 265789, I/A 47 ( 3.10.14).
04 de Agosto de 2014Revocaciones. APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA. Datos registrales. T 44284, F 183, S 8, H B 265789, I/A 46 (25.07.14).
24 de Abril de 2014Revocaciones. APODERADO: BADRENAS JUNYENT JOSE;CASAJUANA MIRAS ALBERT;SANCHEZ RUIZ ANTONIO. Datosregistrales. T 39032 , F 225, S 8, H B 265789, I/A 43 (15.04.14).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GALOPA VILARET JOSEP MARIA;MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;RODRIGUEZ SANTACRUZ BENITO Datos registrales. T 39032 , F 225, S 8, H B 265789, I/A 44 (15.04.14).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CULLELL VILARO MARC. Datos registrales. T 44284 , F 182, S 8, H B 265789, I/A 45(15.04.14).
26 de Febrero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 158.120.419,00 Euros. Resultante Suscrito: 700.000,00 Euros. Datos registrales. T 39032, F 225, S 8, H B 265789, I/A 42 (17.02.14).
03 de Enero de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 224, S 8, H B 265789, I/A 40 (24.12.13).
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 225, S 8, H B 265789, I/A 41 (24.12.13).
31 de Enero de 2013Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 224, S 8, H B 265789, I/A 38 (23.01.13).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 224, S 8, H B 265789, I/A 39 (23.01.13).
02 de Febrero de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 36 (24.01.12).
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 37 (24.01.12).
02 de Enero de 2012Otros conceptos: RECTIFICADO EL DNI DEL APODERADO DON JUAN MANUEL MARQUEZ GOMEZ. Datos registrales. T39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 35 (20.12.11).
06 de Mayo de 2011Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCET BENET. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELL SANTACANARAMON. Datos registrales. T 39032 , F 223, S 8, H B 265789, I/A 34 (20.04.11).
24 de Enero de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 222, S 8, H B 265789, I/A 32 (12.01.11).
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 222, S 8, H B 265789, I/A 33 (12.01.11).
12 de Enero de 2011Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FORAT 19 SL. COPCISA CAPITAL SL. Datos registrales. T 39032 , F 219, S 8, H B265789, I/A 31 (29.12.10).
22 de Noviembre de 2010Revocaciones. APODERADO: BELLAFONT ALVARO LUIS. Datos registrales. T 39032 , F 219, S 8, H B 265789, I/A 30 ( 5.11.10).
11 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.207.527,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.820.419,00 Euros. Datos registrales. T 39032 , F217, S 8, H B 265789, I/A 29 (28.10.10).
02 de Noviembre de 2010Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ RUIZ ANTONIO. Datos registrales. T 39032 , F 215, S 8, H B 265789, I/A 28(20.10.10).
13 de Julio de 2010Revocaciones. APODERADO: LLENA NICOLAU JUAN CARLOS. Datos registrales. T 39032 , F 215, S 8, H B 265789, I/A 27 (1.07.10).
24 de Junio de 2010Nombramientos. APODERADO: CASAJUANA MIRAS ALBERT. Datos registrales. T 39032 , F 212, S 8, H B 265789, I/A 26(11.06.10).
16 de Marzo de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 211, S 8, H B 265789, I/A 24 ( 3.03.10).
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: DELOITTE SL. Datos registrales. T 39032 , F 212, S 8, H B 265789, I/A 25 ( 3.03.10).
10 de Marzo de 2010Revocaciones. REPR.143 RRM: CARBONELL TARRES JOSEP. Nombramientos. REPR.143 RRM: CARBONELL MARCETBENET. Datos registrales. T 39032 , F 211, S 8, H B 265789, I/A 23 (24.02.10).
08 de Febrero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 717.676,00 Euros. Resultante Suscrito: 130.612.892,00 Euros. Datos registrales. T 39032 , F 210, S8, H B 265789, I/A 22 (26.01.10).
24 de Diciembre de 2009Nombramientos. APODERADO: MARQUEZ GOMEZ JUAN MANUEL;GALOPA VILARET JOSEP MARIA. Datos registrales. T39032 , F 208, S 8, H B 265789, I/A 21 (15.12.09).
05 de Octubre de 2009Revocaciones. APODERADO: PALOUZIE SARRAT JOSE FELIX. Datos registrales. T 39032 , F 208, S 8, H B 265789, I/A 20(22.09.09).
09 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.647.414,00 Euros. Resultante Suscrito: 129.895.216,00 Euros. Datos registrales. T 39032 , F 207,S 8, H B 265789, I/A 19 (28.08.09).
25 de Junio de 2009Revocaciones. APODERADO: HUGO PUGLISI. Datos registrales. T 39032 , F 207, S 8, H B 265789, I/A 18 (15.06.09).