Buscador CIF Logo

Actos BORME Copersucar Europe Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Copersucar Europe Sociedad Limitada

Actos BORME Copersucar Europe Sociedad Limitada - B95902839

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Copersucar Europe Sociedad Limitada con CIF B95902839

馃敊 Perfil de Copersucar Europe Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Copersucar Europe Sociedad Limitada

21 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: CARDOSO DA SILVA ALINE;SIQUEIRA SAMEJIMA VANESSA. Datos registrales. T 5738 , F 163, S8, H BI 70737, I/A 21 (13.09.23).

31 de Mayo de 2023
Cambio de domicilio social. C/ BUENOS AIRES 12 (BILBAO). Datos registrales. T 5738 , F 163, S 8, H BI 70737, I/A 20(18.05.23).

20 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: MORENO MAIARA FAVARETTO. Otros conceptos: Cesada DO脩A MAIARA FAVARETTO MORENOcomo gerente de la sucursal en Rotterdam y nombrada DO脩A ALIME CARDOSO DA SILVA para tal cargo. Datos registrales. T 5738, F 163, S 8, H BI 70737, I/A 19 (13.04.23).

28 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5738 , F 163, S 8, H BI 70737, I/A 18(17.03.23).

17 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5738 , F 163, S 8, H BI 70737, I/A16 ( 9.11.22).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ALONSO FERNANDEZ MARIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: ORTEGA ESPILLA OLATZ.Datos registrales. T 5738 , F 163, S 8, H BI 70737, I/A 17 ( 9.11.22).

18 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: POGETTI LUIS ROBERTO;MANZANO TOMAS CAETANO;JAUREGUI ARCO SANTIAGO;MARTINEZMAESO LORENZO;MUGICA LANDA MARTIN. Datos registrales. T 5738 , F 78, S 8, H BI 70737, I/A 13 ( 5.08.22).

Nombramientos. Apoderado: MORENO MAIARA FAVARETTO;CARDOSO DA SILVA ALINE;SIQUEIRA SAMEJIMA VANESSA.Datos registrales. T 5738 , F 81, S 8, H BI 70737, I/A 14 ( 5.08.22).

Revocaciones. Apoderado: POGETTI LUIS ROBERTO;GONCALVES TEIXEIRA JOAO ROBERTO;JAUREGUI ARCOSANTIAGO;MARTINEZ MAESO LORENZO;MUGICA LANDA MARTIN;FAVARETTO MORENO MAIARA;CARDOSO DA SILVAALINE. Datos registrales. T 5738 , F 162, S 8, H BI 70737, I/A 15 ( 5.08.22).

18 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONCALVES TEIXEIRA JOAO ROBERTO. Nombramientos. Consejero: MANZANO TOMASCAETANO. Datos registrales. T 5738 , F 78, S 8, H BI 70737, I/A 12 ( 1.04.22).

25 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: KNORR GOMEZA LUIS GONZAGA. Nombramientos. VsecrNoConsj: ALONSO FERNANDEZMARIA. Otros conceptos: Cesado DON CHARLES HENRIQUE GARCIA como Gerente y apoderado de la sucursal COPERSUCAREUROPE, S.L., SUCURSAL EN ROTTERDAM, y nombrada DO脩A MAIARA FAVARETTO MORENO como nueva Gerente yapoderada de dicha Sucursal. Datos registrales. T 5738 , F 77, S 8, H BI 70737, I/A 11 (15.11.21).

05 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: FAVARETTO MORENO MAIARA;CARDOSO DA SILVA ALINE. Datos registrales. T 5738 , F 77, S 8,

10 de Marzo de 2020
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Nombrado "KPMG ACCOUNTANTS NV"como Auditor de Cuentas de la Sucursal en Rotterdam para los ejercicios que finalizan el 31 de Marzo de 2020 y el 31 de Marzo de2021. Datos registrales. T 5738 , F 76, S 8, H BI 70737, I/A 9 (28.02.20).

07 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: KLINGENBERG PEIRONCELY IGNACIO. Nombramientos. Secretario: IRASTORZAMARTINEZ IRANTZU. Datos registrales. T 5738 , F 76, S 8, H BI 70737, I/A 8 (30.10.19).

30 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ARMENDARIZ ROMAN JON. Nombramientos. SecreNoConsj: KLINGENBERG PEIRONCELYIGNACIO. Datos registrales. T 5738 , F 76, S 8, H BI 70737, I/A 7 (20.05.19).

30 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SOUZA PAULO ROBERTO. Nombramientos. Consejero: GONCALVES TEIXEIRA JOAOROBERTO. Datos registrales. T 5738 , F 74, S 8, H BI 70737, I/A 4 (16.04.19).

Revocaciones. Apoderado: DE SOUZA PAULO ROBERTO. Datos registrales. T 5738 , F 74, S 8, H BI 70737, I/A 5 (16.04.19).

Nombramientos. Apoderado: POGETTI LUIS ROBERTO;GONCALVES TEIXEIRA JOAO ROBERTO;JAUREGUI ARCOSANTIAGO;MARTINEZ MAESO LORENZO;MUGICA LANDA MARTIN. Datos registrales. T 5738 , F 74, S 8, H BI 70737, I/A 6(16.04.19).

21 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Apertura de sucursal en Rotterdam con la denominaci贸n de "COPERSUCAR EUROPE SL, Sucursal enRotterdam". Se designa como Gerente de la Sucursal a Don Charles Henrique Garcia. Otorgamiento de poder a favor de Don CharlesHenrique Garcia y Do帽a Maiara Favaretto Moreno. Datos registrales. T 5738 , F 73, S 8, H BI 70737, I/A 3 (11.12.18).

22 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARBATI GOMEZ PAULA. Revocaciones. Apoderado: ECHARANDIO ELOSEGUI JAGOBA.Nombramientos. SecreNoConsj: ARMENDARIZ ROMAN JON. VsecrNoConsj: KNORR GOMEZA LUIS GONZAGA. Datosregistrales. T 5738 , F 73, S 8, H BI 70737, I/A 2 (12.11.18).

28 de Diciembre de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.12.17. Objeto social: LA PRODUCCION, COMPRA, TRANSFORMACION, VENTA,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE AZUCARES... Domicilio: C/ GRAN VIA 19-21 2陋 (BILBAO). Capital:30.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: COPERSUCAR SOCIEDAD ANONIMA. Nombramientos.Consejero: POGETTI LUIS ROBERTO;DE SOUZA PAULO ROBERTO;JAUREGUI ARCO SANTIAGO;MARTINEZ MAESOLORENZO;MUGICA LANDA MARTIN. Presidente: POGETTI LUIS ROBERTO. Vicepresid.: JAUREGUI ARCO SANTIAGO.SecreNoConsj: GARBATI GOMEZ PAULA. Apoderado: ECHARANDIO ELOSEGUI JAGOBA;JAUREGUI ARCO SANTIAGO;DE

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n