Actos BORME de Coreco Sa
09 de Octubre de 2023Revocaciones. Auditor: Q2 AUDITORIA LEGAL Y FINANCIERA SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datosregistrales. T 2091 , F 17, S 8, H CO 5321, I/A 34 ( 2.10.23).
22 de Junio de 2023Modificaciones estatutarias. 7. Acciones/Participaciones.-. 8. Acciones/Participaciones.-. 10. Acciones/Participaciones.-. 11.Acciones/Participaciones.-. 12. Acciones/Participaciones.-. 14. Acciones/Participaciones.-. 23. Acciones/Participaciones.-. Datosregistrales. T 2091 , F 16, S 8, H CO 5321, I/A 33 (14.06.23).
03 de Marzo de 2023Nombramientos. Con.Delegado: PE脩ALVER LOPEZ JOAQUIN ALBERTO. Datos registrales. T 2091 , F 16, S 8, H CO 5321, I/A32 (24.02.23).
09 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE. Con.Ind.: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE. Vicepresid.: JUAREZ
13 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Vicepresid.: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Consejero: JUAREZ HOYOSPEDRO JOSE;MELLADO CASTRO MANUEL. Presidente: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. SecreNoConsj: TELLEZ MARQUEZ ANTONIOJAVIER. Nombramientos. Consejero: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Presidente: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Consejero: JUAREZHOYOS PEDRO JOSE. Con.Ind.: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE. Vicepresid.: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE. Consejero:MELLADO CASTRO MANUEL;PE脩ALVER LOPEZ JOAQUIN ALBERTO. SecreNoConsj: TELLEZ MARQUEZ ANTONIO JAVIER.Datos registrales. T 2091 , F 15, S 8, H CO 5321, I/A 30 ( 3.06.22).
09 de Febrero de 2022Revocaciones. Auditor: QRS AUDITORIA SLP. Nombramientos. Auditor: Q2 AUDITORIA LEGAL Y FINANCIERA SL. Datosregistrales. T 2077 , F 201, S 8, H CO 5321, I/A 29 ( 3.02.22).
19 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: JUAREZ CASTRO INMACULADA. Datos registrales. T 2077 , F 199, S 8, H CO 5321, I/A 28(12.12.19).
03 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: QRS AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2077 , F 198, S 8, H CO 5321, I/A 27 (27.11.19).
05 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO. Presidente: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO.Nombramientos. Presidente: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Cambio de domicilio social. CTRA CORDOBA-MALAGA Km 80,800(LUCENA). Datos registrales. T 2077 , F 198, S 8, H CO 5321, I/A 26 (27.03.19).
15 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: QRS AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2077 , F 198, S 8, H CO 5321, I/A 25 ( 7.11.17).
13 de Febrero de 2017Reelecciones. SecreNoConsj: TELLEZ MARQUEZ ANTONIO JAVIER. Consejero: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO.Presidente: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO. Consejero: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Vicepresid.: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN.Consejero: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE;MELLADO CASTRO MANUEL. Datos registrales. T 2077 , F 197, S 8, H CO 5321, I/A24 ( 6.02.17).
01 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GRADIT GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 2077 , F 197, S 8, H CO 5321, I/A 23 (25.05.16).
18 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: QRS AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2077 , F 196, S 8, H CO 5321, I/A 22 (11.11.14).
14 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO. Presidente: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO.Consejero: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE. Vicepresid.: JUAREZ HOYOS PEDRO JOSE. Cons.Del.Sol: JUAREZ HOYOS PEDROJOSE. Consejero: MELLADO CASTRO MANUEL. Cons.Del.Sol: MELLADO CASTRO MANUEL. Secretario: TELLEZ MARQUEZANTONIO JAVIER. Nombramientos. Consejero: CORTES JIMENEZ PEDRO ANTONIO. Presidente: CORTES JIMENEZ PEDROANTONIO. Consejero: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Vicepresid.: LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN. Consejero: JUAREZ HOYOS PEDROJOSE;MELLADO CASTRO MANUEL;GRADIT GARCIA PEDRO. SecreNoConsj: TELLEZ MARQUEZ ANTONIO JAVIER. Datosregistrales. T 2077 , F 195, S 8, H CO 5321, I/A 20 ( 3.08.12).
Nombramientos. Apoderado: PE脩ALVER LOPEZ JOAQUIN ALBERTO. Datos registrales. T 2077 , F 196, S 8, H CO 5321, I/A 21 (3.08.12).
07 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 25.845,15 Euros. Desembolsado: 25.845,15 Euros. Resultante Suscrito: 85.950,15 Euros.Resultante Desembolsado: 85.950,15 Euros. Cambio de objeto social. Fabricaci贸n y comercializaci贸n en mercados nacionales yexteriores de aparatos frigor铆ficos, calefactores, maquinaria y aparatos de hosteler铆a, dom茅sticos e industriales, con cuanto le fuerecomplemento, o estuviere conexo oresultare necesario para ello. As铆 como la explotaci贸n directa, o bien la g. Fusi贸n por absorci贸n.Sociedades absorbidas: FABRICADOS ESPECIALES CORECO SA. CORECO EXPORT SL. Datos registrales. T 2077 , F 194, S 8,H CO 5321, I/A 19 (26.01.12).
04 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: PE脩ALVER LOPEZ JOAQUIN ALBERTO. Datos registrales. T 755 , F 225, S 8, H CO 5321, I/A 18(25.10.11).
18 de Octubre de 2011Otros conceptos: Queda depositada la mofificaci贸n del Proyecto de Fusi贸n porAbsorci贸n de la sociedad CORECO SA (SociedadAbsorbente) y CORECO EXPORT SL y FABRICADOS EXPECIALES CORECO SA (Sociedades Absorbidas). Datos registrales. T755 , F 225, S 8, H CO 5321, I/A 17 N ( 6.10.11).
18 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: QRS AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 755 , F 225, S 8, H CO 5321, I/A 17 ( 7.10.10).