Actos BORME de Corpfin Capital Prime Retail Ii Socimi Sa
17 de Marzo de 2023Modificaciones estatutarias. RENUNCIA AL REGIMEN DE SOCIMI, MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1º, 2º 7º BIS, 7º TRIS,27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y SUPRESION DEL ARTICULO 30º DE LOS MISMOS.. Cambio de denominación social.CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SA. Cambio de objeto social. LA ADQUISICION Y PROMOCION DE BIENES INMUEBLES
05 de Mayo de 2022Reducción de capital. Importe reducción: 4.657.268,80 Euros. Resultante Suscrito: 5.093.887,75 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 32471 , F 218, S 8, H M 565728, I/A 17 (27.04.22).
31 de Marzo de 2022Modificaciones estatutarias. Modificado el articulo 11 de los estatutos sociales; introducido un nuevo articulo 11 bis a los estatutossociales . Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.corpfincapitalprimeretailiisocimi.com. Datosregistrales. T 32471 , F 216, S 8, H M 565728, I/A 15 (24.03.22).
Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA-TAPIA GONZALEZ-CAMINO RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: GRANADOLAPUENTE ANA. Reelecciones. Consejero: BASAGOITI MIRANDA JAVIER;RUXPIN 99 SL;FINMASER DIVERSIFICACIONSL;MARFECO SL;VALDEFINCIAS SL;AS INVERSIONES SL;HASHMI EJAZ AHMED. Presidente: BASAGOITI MIRANDA JAVIER.Con.Delegado: BASAGOITI MIRANDA JAVIER. Representan: LAVILLA RUBIRA CARLOS;GARCIA BEJINES JOSEMANUEL;GIESSO CAZENAVE MIRTA;SERRATOSA LUJAN BEGOÑA;MARTINAVARRO FERRER ENRIQUE. Datos registrales. T32471 , F 217, S 8, H M 565728, I/A 16 (24.03.22).
03 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32471 , F 216, S 8, H M 565728, I/A 14 (27.01.21).
03 de Agosto de 2020Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 57 - 4º (MADRID). Datos registrales. T 32471 , F 215, S 8, H M 565728, I/A 13(27.07.20).
19 de Septiembre de 2019Reducción de capital. Importe reducción: 4.802.808,45 Euros. Resultante Suscrito: 9.751.156,55 Euros. Datos registrales. T 32471, F 215, S 8, H M 565728, I/A 12 (12.09.19).
12 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32471 , F 214, S 8, H M 565728, I/A 11 ( 2.02.18).
27 de Octubre de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32471 , F 214, S 8, H M 565728, I/A 10(20.10.15).
24 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARCIA-TAPIA GONZALEZ-CAMINO RAFAEL-FERNANDO;FRANCISCO JAVIER BASAGOITIMIRANDA. Nombramientos. Secretario: GARCIA TAPIA GONZALEZ CAMINO RAFAEL. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTIONDE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Representan: LAVILLA RUBIRA CARLOS;SERRATOSA LUJAN BEGOÑA;MARTINAVARROFERRER ENRIQUE;GARCIA BEJINES JOSE MANUEL. Consejero: BASAGOITI MIRANDA JAVIER;RUXPIN 99 SL;FINMASERDIVERSIFICACION SL;MARFECO SL;VALDEFINCIAS SL;AS INVERSIONES SL;HASHMI EJAZ AHMED. Presidente: BASAGOITIMIRANDA JAVIER. Con.Delegado: BASAGOITI MIRANDA JAVIER. Representan: GIESSO CAZENAVE MIRTA. Modificacionesestatutarias. Modificación de los artículos 6º, 7º, 11º, 13ºy 15º. Se añaden los artículos 7º bis, 7º tris y 32º. . Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. Modificación del sistema derepresentación de las acciones, transformándolas en anotaciones en cuenta. Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 57 - 5ºPLANTA (MADRID). Datos registrales. T 32471 , F 211, S 8, H M 565728, I/A 9 (17.09.15).
29 de Junio de 2015Ampliación de capital. Capital: 3.304.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.404.000,00 Euros. Ampliación de capital. Capital: