Actos BORME de Corporacion De Practicos Del Puerto De Gijon Sociedad Limitada Profesional
24 de Julio de 2023Nombramientos. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3959 , F 169, S 8, H AS43593, I/A 18 (17.07.23).
16 de Enero de 2023Revocaciones. Soc.Prof.: ALVAREZ FERNANDEZ RAMON ALBERTO. Nombramientos. Soc.Prof.: FERNANDEZ-CAMPOAMORZUAZUA JOSE LUIS. Otros conceptos: El socio ALVAREZ FERNANDEZ RAMON ALBERTO transmite un n煤mero de 1participaciones al socio FERNANDEZ-CAMPOAMOR ZUAZUA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3959 , F 169, S 8, H AS 43593, I/A17 ( 5.01.23).
02 de Febrero de 2022Revocaciones. Soc.Prof.: RAYO FERNANDEZ JOAQUIN ANGEL. Nombramientos. Soc.Prof.: FERNANDEZ PEREZ PABLO.Otros conceptos: El socio RAYO FERNANDEZ, JOAQUIN ANGEL transmite 1 participacion al socio FERNANDEZ PEREZ, PABLO.Datos registrales. T 3959 , F 169, S 8, H AS 43593, I/A 14 (24.01.22).
Revocaciones. Soc.Prof.: MENENDEZ FACHADO BENITO. Nombramientos. Soc.Prof.: GARCIA SUAREZ IGNACIO. Otrosconceptos: El socio MENENDEZ FACHADO, BENITO transmite 1 participaci贸n al socio GARCIA SUAREZ, IGNACIO. Datosregistrales. T 3959 , F 169, S 8, H AS 43593, I/A 15 (24.01.22).
Nombramientos. Consejero: GARCIA SUAREZ IGNACIO. Datos registrales. T 3959 , F 169, S 8, H AS 43593, I/A 16 (24.01.22).
17 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ FACHADO BENITO. Datos registrales. T 3959 , F 168, S 8, H AS 43593, I/A 13 (9.11.21).
16 de Noviembre de 2021Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ PEREZ PABLO. Datos registrales. T 3959 , F 168, S 8, H AS 43593, I/A 12 ( 3.11.21).
12 de Abril de 2021Nombramientos. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3959 , F 168, S 8, H AS43593, I/A 11 ( 5.04.21).
04 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: RAYO FERNANDEZ JOAQUIN ANGEL. Datos registrales. T 3959 , F 168, S 8, H AS 43593, I/A 10(23.02.21).
02 de Febrero de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Domicilio social.-. Cambio de domicilio social. PTO DE EL MUSEL -EDIFICIO DE SERVICIOS LOGISTICO (GIJON). Datos registrales. T 3959 , F 168, S 8, H AS 43593, I/A 9 (25.01.21).
08 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: CABALLERO CANTERO ANGEL. Secretario: MENENDEZ FACHADO BENITO. Cons.Del.Sol:BRA脩A ARGUELLES JOSE CARLOS;RAYO FERNANDEZ JOAQUIN ANGEL;CABALLERO CANTERO ANGEL Nombramientos.Presidente: CABALLERO CANTERO ANGEL. Secretario: BRA脩A ARGUELLES JOSE CARLOS. Cons.Del.Sol: BRA脩A ARGUELLESJOSE CARLOS;CABALLERO CANTERO ANGEL. Reelecciones. Consejero: CABALLERO CANTERO ANGEL;MENENDEZFACHADO BENITO;BRA脩A ARGUELLES JOSE CARLOS;RAYO FERNANDEZ JOAQUIN ANGEL. Datos registrales. T 3959 , F167, S 8, H AS 43593, I/A 8 (31.08.20).
10 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3959 , F 167, S 8, H AS43593, I/A 7 ( 1.08.17).
25 de Enero de 2017Nombramientos. Cons.Del.Sol: CABALLERO CANTERO ANGEL. Datos registrales. T 3959 , F 167, S 8, H AS 43593, I/A 6(17.01.17).
27 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: BRA脩A ARGUELLES JOSE CARLOS. Secretario: RAYO FERNANDEZ JOAQUIN ANGEL.Cons.Del.Sol: CABALLERO CANTERO ANGEL;MENENDEZ FACHADO BENITO. Nombramientos. Presidente: CABALLEROCANTERO ANGEL. Secretario: MENENDEZ FACHADO BENITO. Cons.Del.Sol: BRA脩A ARGUELLES JOSE CARLOS;RAYOFERNANDEZ JOAQUIN ANGEL. Reelecciones. Consejero: CABALLERO CANTERO ANGEL;MENENDEZ FACHADOBENITO;BRA脩A ARGUELLES JOSE CARLOS;RAYO FERNANDEZ JOAQUIN ANGEL. Datos registrales. T 3959 , F 167, S 8, H AS43593, I/A 5 (19.09.16).
05 de Diciembre de 2014Nombramientos. Auditor: FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC. Datos registrales. T 3959 , F 167, S 8, H AS43593, I/A 4 (27.11.14).
05 de Septiembre de 2014Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13.3 REFERENTE A RETRIBUCION DEL ORGANO ADMINISTRADOR,17DE CUOTA DE LIQUIDACION Y 19 DE LA RESERVA VOLUNTARIA. Datos registrales. T 3959 , F 165, S 8, H AS 43593, I/A 3(28.08.14).
28 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Soc.Prof.: GUTIERREZ ALONSO MARCO ANTONIO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.837,00Euros. Resultante Suscrito: 11.022,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales.T 3959 , F 165, S 8, H AS 43593, I/A 2 (15.11.12).