Actos BORME de Corporacion Empresarial Valls Sl
04 de Noviembre de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 42606 , F 74, S 8, H B 33498, I/A 134 (26.10.22).
18 de Agosto de 2022Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: FISIN S.L. Datos registrales. T 42606 , F 74, S 8, H B33498, I/A 133 (10.08.22).
24 de Enero de 2020Nombramientos. APOD.SOL/MAN: VALLS BIOSCA CLARA. Datos registrales. T 42606 , F 73, S 8, H B 33498, I/A 132 (14.01.20).
18 de Noviembre de 2019Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 42606 , F 73, S 8, H B 33498, I/A 131 ( 8.11.19).
26 de Abril de 2017Revocaciones. CONSEJERO: ARNAU ARANDA LUIS. SECRETARIO: ARNAU ARANDA LUIS. Nombramientos. SECRETARIO:TORRES CASTELLO XAVIER. Datos registrales. T 42606 , F 73, S 8, H B 33498, I/A 130 (18.04.17).
25 de Noviembre de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 42606 , F 73, S 8, H B 33498, I/A 129 (17.11.16).
25 de Marzo de 2015Revocaciones. CONS. DELEG.: VALLS BIOSCA MARTA. Datos registrales. T 42606 , F 72, S 8, H B 33498, I/A 127 (17.03.15).
Nombramientos. DTOR.GENERAL: VALLS BIOSCA MARTA. Datos registrales. T 42606 , F 72, S 8, H B 33498, I/A 128 (17.03.15).
11 de Octubre de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 42606 , F 72, S 8, H B 33498, I/A 126 ( 3.10.13).
26 de Diciembre de 2012Nombramientos. APODERADO: TORRES CASTELLO JAVIER. Datos registrales. T 42606 , F 71, S 8, H B 33498, I/A 125(17.12.12).
27 de Mayo de 2011Nombramientos. APODERADO: VALLS BIOSCA GLORIA. Datos registrales. T 32658 , F 150, S 8, H B 33498, I/A 124 (16.05.11).