Buscador CIF Logo

Actos BORME Corporacion F Turia Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Corporacion F Turia Sa

Actos BORME Corporacion F Turia Sa - A46003265

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Corporacion F Turia Sa con CIF A46003265

🔙 Perfil de Corporacion F Turia Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Corporacion F Turia Sa

13 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: BLANCO COLL SANTIAGO;GARCIA GARCIA RAFAEL;SERRANO LOPEZ ALEJANDRA;ARACARRASCOSA CARLOS. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 20, S 8, H V 5968, I/A 176 ( 5.09.23).

23 de Agosto de 2023
Reelecciones. Consejero: GIMENEZ VILA BELDA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 20, S 8, H V 5968, I/A 175(16.08.23).

30 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Aud.C.Con.: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datosregistrales. T 8501, L 5791, F 20, S 8, H V 5968, I/A 174 (23.09.22).

04 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN;CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Presidente: CARPI CAÑELLASSEBASTIAN. Vicepresid.: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Con.Delegado: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Nombramientos.Consejero: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN;CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Presidente: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN. Vicepresid.:CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Con.Delegado: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Modificaciones estatutarias. Modificada laredacción del ARTICULO 18º.- . Modificada la redacción del ARTICULO 20º.- . Modificada la redacción del ARTICULO 32º.- . Datosregistrales. T 8501, L 5791, F 19, S 8, H V 5968, I/A 173 (28.07.22).

21 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: BLANCO COLL SANTIAGO. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 19, S 8, H V 5968, I/A 172(15.10.21).

28 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPI CAÑELLAS MARIA MIGUELA. Reelecciones. Consejero: MALDONADO RUBIO JOAQUIN.Datos registrales. T 8501, L 5791, F 18, S 8, H V 5968, I/A 171 (21.07.21).

08 de Enero de 2021
Reelecciones. Consejero: ZELARD INVERSIONES SL. Secretario: ZELARD INVERSIONES SL. Otros conceptos: La sociedad"ZELARD INVERSIONES SL", secretaria del Consejo de Administración, designa como persona física representante a DON JAVIERCARPI STOFFEL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 18, S 8, H V 5968, I/A 170 (30.12.20).

01 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Aud.C.Con.: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datosregistrales. T 8501, L 5791, F 18, S 8, H V 5968, I/A 169 (24.09.19).

15 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: INTERFLUMINA INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero: AMNISCARPENSIS SL. Otros conceptos: La persona física representante del Consejero la mercantil "AMNIS CARPENSIS SL" con CIFB40550006 es Don Miguel Rafael Ríos Capapé Carpi con DNI/NIF número 24.349.079-Z. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 17, S8, H V 5968, I/A 167 ( 8.04.19).

26 de Febrero de 2019
Reelecciones. Consejero: RIOS CAPAPE CARPI JACOBO CARLOS. Modificaciones estatutarias. 1. El cargo de administrador esremunerado. Los miembros del Consejo de Administración percibirán una remuneración que consistirá en los siguientes conceptosretributivos: a) Dietas por su asistencia a las sesiones del Consejo de Administración; b) Una participación en beneficios que no podráexcede. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 17, S 8, H V 5968, I/A 166 (19.02.19).

24 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: SERRANO LOPEZ ALEJANDRA. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 17, S 8, H V 5968, I/A 165(17.10.18).

17 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ VILA BELDA JUAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: GIMENEZ VILA BELDAJUAN MANUEL. Reelecciones. Consejero: CARPI CAÑELLAS MARIA MIGUELA. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 16, S 8, H V5968, I/A 164 (10.07.17).

26 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ VILA BELDA JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: GIMENEZ VILA BELDAJUAN MANUEL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 16, S 8, H V 5968, I/A 163 (19.04.17).

30 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Aud.C.Con.: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datosregistrales. T 8501, L 5791, F 16, S 8, H V 5968, I/A 162 (23.11.16).

22 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: CARPI STOFFEL JAVIER. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 15, S 8, H V 5968, I/A 161 (15.09.16).

18 de Julio de 2016
Reelecciones. Consejero: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN;CARPI STOFFEL SEBASTIAN;GIMENEZ VILA BELDA JOSEIGNACIOPresidente: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN. Vicepresid.: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Con.Delegado: CARPI STOFFELSEBASTIAN. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 13, S 8, H V 5968, I/A 160 (11.07.16).

29 de Octubre de 2015
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 1º.-. ARTICULO 6 .. ARTICULO 7. " ARTICULO 7.1.- TRANSMISIONES LIBRES. ART.7.2.-TRANSMISIONES RESTRINGIDAS. ARTICULO 8 . . ARTICULO 16 . ARTICULO 21 . ARTICULO 22 .. ARTICULO 29 . ARTICULO 31.ARTICULO 33 .. "ARTICULO 34º.- . ARTICULO 35º. . ARTICULO 38 . Datos registrales. T 8501, L 5791, F 13, S 8, H V 5968, I/A 159(22.10.15).

10 de Agosto de 2015
Reelecciones. Consejero: MALDONADO RUBIO JOAQUIN. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 12, S 8, H V 5968, I/A 158 (3.08.15).

05 de Agosto de 2014
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.corpturia.com. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 12, S8, H V 5968, I/A 157 (29.07.14).

14 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPI STOFFEL JAVIER. Secretario: CARPI STOFFEL JAVIER. Nombramientos. Consejero:ZELARD INVERSIONES SL;INTERFLUMINA INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA. Secretario: ZELARD INVERSIONES SL.Reducción de capital. Importe reducción: 143.548,04 Euros. Resultante Suscrito: 1.522.716,05 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 14 .-CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 12, S 8, H V5968, I/A 156 ( 7.02.14).

02 de Octubre de 2013
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: UNION DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 8501, L5791, F 10, S 8, H V 5968, I/A 155 (25.09.13).

07 de Agosto de 2013
Nombramientos. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 10, S 8, H V 5968, I/A 154(31.07.13).

03 de Junio de 2013
Modificaciones estatutarias. Se modifica el artículo 7 de los estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de las acciones..Datos registrales. T 8501, L 5791, F 9, S 8, H V 5968, I/A 153 (27.05.13).

22 de Marzo de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 8, S 8, H V 5968, I/A 152 (14.03.13).

11 de Octubre de 2012
Reelecciones. Consejero: RIOS CAPAPE CARPI JACOBO;CARPI STOFFEL JAVIER. Secretario: CARPI STOFFEL JAVIER. Datosregistrales. T 8501, L 5791, F 8, S 8, H V 5968, I/A 151 ( 2.10.12).

23 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 8, S 8, H V 5968, I/A 150 (13.03.12).

09 de Enero de 2012
Reelecciones. Consejero: CARPI CAÑELLAS MARIA MIGUELA. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 8, S 8, H V 5968, I/A 149(28.12.11).

08 de Marzo de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 8, S 8, H V 5968, I/A 148 (25.02.11).

07 de Febrero de 2011
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: CEMENTVAL SL. CEMENTVAL HORMIGONES SL. CEMENTVAL HORMIGONESCENTRO SOCIEDAD DE RESPONSABI. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 6, S 8, H V 5968, I/A 147 (26.01.11).

31 de Agosto de 2010
Nombramientos. Con.Delegado: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Fe de erratas: por error no se publicó en el envio 158 del año2010, el nombramiento de CONSEJERO DELEGADO a favor de DON SEBASTIAN CARPI STOFFEL.- Datos registrales. T 8501, L5791, F 5, S 8, H V 5968, I/A 146 (19.08.10).

30 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN;CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Reelecciones. Consejero:CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN;CARPI STOFFEL SEBASTIAN;GIMENEZ VILA BELDA JOSE IGNACIOPresidente: CARPICAÑELLAS SEBASTIAN. Vicepresid.: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 5, S 8, H V 5968, I/A 146(19.08.10).

10 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 5, S 8, H V 5968, I/A 145 (29.10.09).

07 de Octubre de 2009
Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 34º.- La retribución del Consejo de Administración consistirá en una asignación fija anualque será determinada para cada año por la Junta General de accionistas de la Sociedad, para el ejercicio en curso en el que seadopta, sin que en ningún caso el importe de dicha retribución pueda "ARTICULO 40º.- El beneficio líquido del ejercicio será aquel queresulte de aplicar las disposiciones legales vigentes sobre elaboración de Cuentas Anuales. El beneficio líquidoque resulte, sedistribuirá del siguiente modo: 1º.- La cantidad necesaria, para dotar las reservas que, por disposición "ARTICULO 35º.- El Consejo,usando en la medida que estimeconveniente, de la facultad de delegar, que le otorga el apartado q) del artículo 33 de estos Estatutos,podrá designar, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes, la persona o personas pertenecientes al mismoque. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 5, S 8, H V 5968, I/A 144 (28.09.09).

18 de Septiembre de 2009
Fe de erratas: Por error se publicó como segundo apellido del Consejero Delegado el de Stoffel, cuando en realidad es CAÑELLAS.Datos registrales. T 8501, L 5791, F 4, S 8, H V 5968, I/A 143 ( 1.07.09).

10 de Julio de 2009
Nombramientos. Con.Delegado: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 4, S 8, H V 5968, I/A 143 (1.07.09).

05 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Dir. General: FERNANDEZ PORTOLES MIGUEL ANGEL. Revocaciones. Apoderado: ALONSO CARPIFRANCISCO;VALERO CASTELLANO SALVADOR. Apo.Sol.: CARPI VILAR SEBASTIAN. Apo.Manc.: MOLINS FIGUERASJOAQUIN;GIMENEZ BALADER DAMASO;NAVARRO DE PERALTA TOMAS. Apoderado: CARPI VILAR SEBASTIAN. Apo.Manc.:MORENO LLARIO FRANCISCO;FERRANDO ALBELDA PASCUAL;MORENO LLARIO FRANCISCO;MATAIX ARGENTERICARDO;VAZQUEZ CASTELLS RAMON;MORENO LLARIO FRANCISCO;MATAIX ARGENTE RICARDO;FERRANDO ALBELDAPASCUAL;VAZQUEZ CASTELLS RAMON;GIMENEZ VILA BELDA JOSE IGNACIO. Apoderado: CARPI VILAR SEBASTIAN. Apo.Sol.:CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN. Apoderado: VALERO CASTELLANO SALVADOR;VALERO CASTELLANO SALVADOR. Apo.Manc.:MATAIX ARGENTE RICARDO. Apoderado: GIMENEZ VILA BELDA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 4, S 8, H V5968, I/A 142 (27.05.09).

29 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN. Consejero: SEBASTIAN GASCON VICENTE. Secretario: CARPISTOFFEL JAVIER. Nombramientos. Vicepresid.: CARPI STOFFEL SEBASTIAN. Con.Delegado: CARPI STOFFEL SEBASTIAN.Secretario: CARPI STOFFEL JAVIER. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 3, S 8, H V 5968, I/A 140 (20.01.09).

Revocaciones. Dir. General: CARPI CAÑELLAS SEBASTIAN. Datos registrales. T 8501, L 5791, F 4, S 8, H V 5968, I/A 141(20.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información