Actos BORME de Corporacion Financiera Issos Sl
01 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS. Apo.Sol.: MARTINEZ MARISCAL JOSE JOAQUIN;GONZALEZMARTIN MARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T 45833 , F 130, S 8, H M 444408, I/A 48 (24.11.23).
19 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA LAURA. Apo.Sol.: GOMEZ SANTOS ANA BELEN;DEL VAL MARTINEZ JORGE.Datos registrales. T 24688 , F 225, S 8, H M 444408, I/A 47 (12.09.23).
04 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ GARCIA LAURA. Nombramientos. Representan: ACOSTA RAMIREZ MIGUELPEDRO. Datos registrales. T 24688 , F 225, S 8, H M 444408, I/A 46 (28.08.23).
12 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: DEY SHOMIT;BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO. Datos registrales. T 24688 , F 225, S 8, H M 444408,I/A 45 ( 5.06.23).
20 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: USED ALONSO ENRIQUE. Otros conceptos: modificaci贸n los poderes conferidos por la Sociedad afavor de D. Carlos Montoya Reguera, con DNI 24277302C, mediante escritura p煤blica otorgada ante la Notario de Madrid, D帽a. Mar铆adel Rosario de Miguel Roses, con el n煤mero 2524 de su protocolo que caus贸 la inscripci贸n 25陋 de su hoja. Datos registrales. T 24688, F 224, S 8, H M 444408, I/A 44 (13.01.23).
23 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: USED ALONSO ENRIQUE. Nombramientos. Representan: MONTOYA REGUERA CARLOS.Datos registrales. T 24688 , F 224, S 8, H M 444408, I/A 43 (16.12.22).
13 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA. Nombramientos. Apo.Sol.: NU脩O CANDELA LUIS. Datosregistrales. T 24688 , F 222, S 8, H M 444408, I/A 42 ( 6.09.22).
01 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL. Datos registrales. T 24688 , F 219, S 8, H M444408, I/A 41 (24.06.22).
10 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MARRERO FERNANDEZ-CID SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: DEL VAL MARTINEZ JORGE.Datos registrales. T 24688 , F 218, S 8, H M 444408, I/A 40 ( 1.12.21).
16 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: ARIZCUN MU脩OZ ARANZAZU. Apo.Man.Soli: URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE S.L. Datosregistrales. T 24688 , F 218, S 8, H M 444408, I/A 39 ( 9.11.21).
14 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: SUNCAPITAL MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 24688 , F 217, S 8, H M444408, I/A 38 ( 7.06.21).
13 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICK MARIE. Adm. Mancom.: M.I. ESPRE REAL ESTATESL. Datos registrales. T 24688 , F 217, S 8, H M 444408, I/A 37 ( 6.04.21).
10 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: LABRADOR ARROYO ALBERTO;SANCHEZ TORRE ROQUE;BAZAGA BUSTOS MARIA ANGELES.Datos registrales. T 24688 , F 217, S 8, H M 444408, I/A 36 ( 3.03.21).
14 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ SANTOS ANA BELEN;JIMENEZ CRESPO DULCENOMBRE DE MARIA;MARREROFERNANDEZ-CID SANTIAGO;GONZALEZ MARTIN MARIA MONTSERRAT;GUTIERREZ GARCIA VICTOR;MARIN DE RODA ANA.Datos registrales. T 24688 , F 215, S 8, H M 444408, I/A 35 ( 3.12.20).
05 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE-MARIA;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA. Apo.Sol.:ISTURIZ LAZARO JAVIER;MONTES ALONSO MARIA ANGELES. Datos registrales. T 24688 , F 215, S 8, H M 444408, I/A 34(28.09.20).
02 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE S.L. Datos registrales. T 24688 , F 214, S 8, H M 444408, I/A33 (25.09.20).
03 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: GAMERO ALONSO ESTER;JIMENEZ SANCHEZ SARA. Datos registrales. T 24688 , F 214, S 8, H M444408, I/A 32 (26.11.19).
05 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: SANZ EXPOSITO LUIS-ALBERTO;RANERA BERMUDEZ ELENA;TERAN CONTRERAS JAVIER. Datosregistrales. T 24688 , F 214, S 8, H M 444408, I/A 31 (29.08.19).
07 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO CARBALLO VICTORIA;MARTINEZ MARISCAL JOSE JOAQUIN;BARROSO SAINZDAVID;MONTES ALONSO MARIA ANGELES. Datos registrales. T 24688 , F 212, S 8, H M 444408, I/A 30 (31.05.19).
28 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: ESCOBAR LAGO PILAR. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA;ISTURIZLAZARO JAVIER;GARCIA MALO DE MOLINA MEGIA ELENA;BUSTOS SALGADO ITZIAR;VARELA PAZ MANUEL ALBERTO.Datos registrales. T 24688 , F 207, S 8, H M 444408, I/A 29 (21.05.19).
12 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MARTIN NU脩EZ ISABEL. Datosregistrales. T 24688 , F 207, S 8, H M 444408, I/A 28 ( 5.04.19).
19 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: LOPEZ LUNA EDUARDO;SAYAGUES DIAZ CRISTINA;CEBADA ROLDAN BARBARA;PADILLA DELVAL JUAN CARLOS;RODRIGUEZ ZAMORA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 24688 , F 206, S 8, H M 444408, I/A 27(12.02.19).
14 de Enero de 2019Nombramientos. Adm. Mancom.: M.I. ESPRE REAL ESTATE SL. Representan: COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICKMARIE. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T24688 , F 205, S 8, H M 444408, I/A 26 ( 4.01.19).
15 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: USED ALONSO ENRIQUE;MENDILUCE FRADERA EDUARD;MONTOYA REGUERACARLOS;FERNANDEZ GARCIA LAURA;MONGE RIAT ALEJANDRO;LOPEZ CLEMENTE FERNANDO;BLAZQUEZ MARQUEZADOLFO;PADILLA DEL VAL JUAN CARLOS;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA;AGUSTI ORERO MARIA DELCARMEN;MENDOZA JUEZ BERTA;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MORAGA RAMIREZ JUAN ANTONIO;RONCERO VICENTELUIS;SANZ EXPOSITO LUIS-ALBERTO;RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE;MARTIN FERREIRA EUGENIA LOURDES;MARTINNU脩EZ ISABEL;ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS;MOINELO LOPEZ TANIA;ARIZCUN MU脩OZ ARANZAZU;ESCOBAR LAGOPILAR;RANERA BERMUDEZ ELENA;LABRADOR ARROYO ALBERTO;TERAN CONTRERAS JAVIER;SANCHEZ TORREROQUE;BURSTEDT EMMA HELENA MARTA;RODRIGUEZ ZAMORA JUAN ANTONIO;RUBIO MARTIN ANDREA;BAZAGA BUSTOSMARIA ANGELES;JIMENEZ SANCHEZ SARA;CALVO CARBALLO VICTORIA. Datos registrales. T 24688 , F 201, S 8, H M 444408,I/A 25 ( 5.10.18).
14 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;DEY SHOMIT;BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL;HOFFMANN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;CABALLERO MARTINEZ JOSEGABRIEL;LEFEBVRE PIERRE-YVES;PIAIA ELENA;PAGES SERRA LAIA;ROCH DOROTA MARTA;MOINELO LOPEZTANIA;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE-MARIA;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MORAGA RAMIREZ JUANANTONIO;RONCERO VICENTE LUIS;CEBADA ROLDAN BARBARA;GAMERO ALONSO ESTER;MONTOYA REGUERACARLOS;MARIN DE RODA ANA. Datos registrales. T 24688 , F 200, S 8, H M 444408, I/A 24 ( 7.08.18).
24 de Julio de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: QUASAR FINANCE SL. Datos registrales. T 24688 , F 200, S 8, HM 444408, I/A 23 (17.07.18).
27 de Junio de 2018Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 8潞 y 11潞 de los Estatutos Sociales.-. Datos registrales. T 24688 , F 50, S 8,H M 444408, I/A 22 (19.06.18).
18 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZAMORA DIAZ JUAN MANUEL. Nombramientos. Representan: USED ALONSOENRIQUE;FERNANDEZ GARCIA LAURA. Adm. Mancom.: RENNELL PROPERTIES 2018 SL;MOALA PROPERTIES 2018 SL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de domiciliosocial. PASEO DE LA CASTELLANA 280 - 2陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 24688 , F 49, S 8, H M 444408, I/A 21 (8.06.18).
22 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.290.690,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.209.890,00 Euros. Datos registrales. T 24688 , F 48, S8, H M 444408, I/A 20 (14.02.18).
12 de Junio de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BANCO POPULAR ESPA脩OL SA. Datos registrales. T 24688 , F 48, S 8, H M444408, I/A 19 ( 1.06.17).
13 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: CARABANTE DE LA PLAZA JOSE RAMON;CARABANTE DE LA PLAZA LUIS. Datos registrales. T24688 , F 47, S 8, H M 444408, I/A 17 ( 6.07.15).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 24688 , F 48, S 8, H M 444408, I/A 18 ( 6.07.15).
08 de Julio de 2015Otros conceptos: Rectificaci贸n de la escritura que motiv贸 la inscripci贸n 14& de la hoja registral, en cuanto al segundo apellido delotorgante, siendo el correcto Diaz. Datos registrales. T 24688 , F 47, S 8, H M 444408, I/A 16 (29.06.15).
06 de Julio de 2015Otros conceptos: Rectificaci贸n de la escritura que motiv贸 la inscripci贸n 13& de la hoja registral, en cuanto al segundo apellido deladministrador, siendo el correcto Diaz y a la fecha de celebraci贸n de la junta, siendo la correcta 6 de enero de 2015. Datosregistrales. T 24688 , F 47, S 8, H M 444408, I/A 15 (29.06.15).
02 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: LOPEZ LUNA EDUARDO;SAYAGUES DIAZ CRISTINA. Datos registrales. T 24688 , F 45, S 8, H M444408, I/A 14 (20.02.15).
19 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ BLANCO JOSE FERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico: ZAMORA DIEZ JUANMANUEL. Datos registrales. T 24688 , F 45, S 8, H M 444408, I/A 13 (12.02.15).
11 de Febrero de 2014Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 40 9 (MADRID). Datos registrales. T 24688 , F 45, S 8, H M 444408, I/A12 ( 4.02.14).
13 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: CARABANTE DE LA PLAZA LUIS. Datos registrales. T 24688 , F 44, S 8, H M 444408, I/A 11 (4.12.13).
25 de Octubre de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL. Datos registrales. T24688 , F 44, S 8, H M 444408, I/A 10 (17.10.13).
13 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: CARABANTE DE LA PLAZA JOSE RAMON. Datos registrales. T 24688 , F 43, S 8, H M 444408, I/A
12 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: CARABANTE AGUILERA JOSE RAMON. Datos registrales. T 24688 , F 43, S 8, H M 444408, I/A 8 (4.06.13).
16 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JOSE RAMON CARABANTE DE LA PLAZA. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ BLANCOJOSE FERNANDO. Datos registrales. T 24688 , F 43, S 8, H M 444408, I/A 7 ( 6.06.11).
02 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CARABANTE DE LA PLAZA JOSE RAMON;BOYER SALVADOR MIGUEL. Nombramientos. Adm.Unico: JOSE RAMON CARABANTE DE LA PLAZA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ ORTEGA Y GASSET 30, BAJO (MADRID). Datosregistrales. T 24688 , F 42, S 8, H M 444408, I/A 6 (22.06.09).
11 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: CARABANTE AGUILERA JOSE RAMON. Datos registrales. T 24688 , F 42, S 8, H M 444408, I/A 5(30.01.09).