Actos BORME de Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada
11 de Febrero de 2022Modificaciones estatutarias. ARTICULO 6潞.- La participaci贸n social: contenido de derechos. 6.1.- Cada participaci贸n social cinfiere asu titular propietario la condici贸n de socio, con los derechos legales y estatutarios inherentes a la misma, entre ellos el de participarproporcionalmente en los beneficios repartibles y en el patrimonio resultante a su liquidaci贸n, en el aumento de capi. Datosregistrales. T 1040, L 804, F 44, S 8, H AB 1008, I/A 49 ( 4.02.22).
03 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 1039, L 803, F 126, S 8, H AB 1008, I/A 46(27.12.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 1039, L 803, F 126, S 8, H AB 1008, I/A 47(27.12.21).
Nombramientos. Apoderado: CORCOLES JAQUERO ELOY. Datos registrales. T 1039, L 803, F 127, S 8, H AB 1008, I/A 48(27.12.21).
20 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 44(13.12.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL.Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Consejero:MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Secretario: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ NOELIAMARIA;SANCHEZ HERRAEZ ADORACION. Datos registrales. T 1039, L 803, F 126, S 8, H AB 1008, I/A 45 (13.12.21).
02 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 42(24.02.20).
Nombramientos. Apoderado: MORENO SANCHEZ ANTONIO. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 43(24.02.20).
09 de Octubre de 2019Revocaciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Nombramientos. Aud.C.Con.: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Su.C.Con: RAMIREZ CARBONERAS JESUSMANUEL. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 41 ( 1.10.19).
19 de Diciembre de 2018Nombramientos. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 40 (12.12.18).
10 de Julio de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.309.098,20 Euros. Resultante Suscrito: 5.236.753,40 Euros. Datos registrales. T 962, L726, F 63, S 8, H AB 1008, I/A 39 ( 3.07.17).
14 de Octubre de 2016Revocaciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Nombramientos. Aud.C.Con.: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.C.C: RAMIREZ CARBONERAS JESUSMANUEL. Datos registrales. T 962, L 726, F 63, S 8, H AB 1008, I/A 38 ( 6.10.16).
10 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL. Datosregistrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A 37 ( 2.12.15).
29 de Junio de 2015Nombramientos. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Datos registrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A 36 (22.06.15).
07 de Abril de 2014Cambio de domicilio social. PQUE EMPRESARIAL AJUSA - CM 332, KM 2.2, CALLE 1, (ALBACETE). P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.corporacionhms.com. Datos registrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008,I/A 35 (31.03.14).
08 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A34 ( 1.04.13).
28 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: VERGARA TRUJILLO PEDRO. Datos registrales.T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A 33 (17.11.11).
16 de Septiembre de 2011Ampliacion del objeto social. La adquisici贸n, enajenaci贸n, explotaci贸n y arrendamiento de fincas, tanto r煤sticas como urbanas, quela Sociedad adquiera por cualquier t铆tulo de dominio, y el arrendamiento de servicios generales. Asimismo la Sociedad podr谩realizarcontrataciones de operaciones inmobiliarias, promoci贸n y construcc. Datos registrales. T 903, L 667, F 4, S 8, H AB 1008, I/A 32 (7.09.11).
26 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 899, L 663, F 117, S 8, H AB 1008, I/A31 (17.01.11).
27 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 881, L 645, F 41, S 8, H AB 1008, I/A 30(17.09.10).
12 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ HERRAEZ ADORACION. Nombramientos. Secretario: MARTINEZ SANCHEZCONSUELO. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Reelecciones. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSEMANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 881, L 645, F 41, S 8, H AB 1008, I/A 29 (3.08.10).
24 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 86.123,30 Euros. Resultante Suscrito: 6.545.851,60 Euros. Datos registrales. T 881, L 645, F 41, S8, H AB 1008, I/A 28 (15.12.09).
17 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA. Datos registrales. T 859, L 623, F 167, S 8, H AB 1008, I/A 27 (6.02.09).