Buscador CIF Logo

Actos BORME Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada

Actos BORME Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada - B02053726

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada con CIF B02053726

馃敊 Perfil de Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Corporacion Hms Hermasan Sociedad Limitada

11 de Febrero de 2022
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 6潞.- La participaci贸n social: contenido de derechos. 6.1.- Cada participaci贸n social cinfiere asu titular propietario la condici贸n de socio, con los derechos legales y estatutarios inherentes a la misma, entre ellos el de participarproporcionalmente en los beneficios repartibles y en el patrimonio resultante a su liquidaci贸n, en el aumento de capi. Datosregistrales. T 1040, L 804, F 44, S 8, H AB 1008, I/A 49 ( 4.02.22).

03 de Enero de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 1039, L 803, F 126, S 8, H AB 1008, I/A 46(27.12.21).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 1039, L 803, F 126, S 8, H AB 1008, I/A 47(27.12.21).

Nombramientos. Apoderado: CORCOLES JAQUERO ELOY. Datos registrales. T 1039, L 803, F 127, S 8, H AB 1008, I/A 48(27.12.21).

20 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 44(13.12.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL.Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Consejero:MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Secretario: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ NOELIAMARIA;SANCHEZ HERRAEZ ADORACION. Datos registrales. T 1039, L 803, F 126, S 8, H AB 1008, I/A 45 (13.12.21).

02 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 42(24.02.20).

Nombramientos. Apoderado: MORENO SANCHEZ ANTONIO. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 43(24.02.20).

09 de Octubre de 2019
Revocaciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Nombramientos. Aud.C.Con.: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Su.C.Con: RAMIREZ CARBONERAS JESUSMANUEL. Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 41 ( 1.10.19).

19 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Datos registrales. T 985, L 749, F 1, S 8, H AB 1008, I/A 40 (12.12.18).

10 de Julio de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.309.098,20 Euros. Resultante Suscrito: 5.236.753,40 Euros. Datos registrales. T 962, L726, F 63, S 8, H AB 1008, I/A 39 ( 3.07.17).

14 de Octubre de 2016
Revocaciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Nombramientos. Aud.C.Con.: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.C.C: RAMIREZ CARBONERAS JESUSMANUEL. Datos registrales. T 962, L 726, F 63, S 8, H AB 1008, I/A 38 ( 6.10.16).

10 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL. Datosregistrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A 37 ( 2.12.15).

29 de Junio de 2015
Nombramientos. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: RAMIREZ CARBONERAS JESUS MANUEL.Datos registrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A 36 (22.06.15).

07 de Abril de 2014
Cambio de domicilio social. PQUE EMPRESARIAL AJUSA - CM 332, KM 2.2, CALLE 1, (ALBACETE). P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.corporacionhms.com. Datos registrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008,I/A 35 (31.03.14).

08 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A34 ( 1.04.13).

28 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: MU脩OZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Aud.Supl.: VERGARA TRUJILLO PEDRO. Datos registrales.T 910, L 674, F 18, S 8, H AB 1008, I/A 33 (17.11.11).

16 de Septiembre de 2011
Ampliacion del objeto social. La adquisici贸n, enajenaci贸n, explotaci贸n y arrendamiento de fincas, tanto r煤sticas como urbanas, quela Sociedad adquiera por cualquier t铆tulo de dominio, y el arrendamiento de servicios generales. Asimismo la Sociedad podr谩realizarcontrataciones de operaciones inmobiliarias, promoci贸n y construcc. Datos registrales. T 903, L 667, F 4, S 8, H AB 1008, I/A 32 (7.09.11).

26 de Enero de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 899, L 663, F 117, S 8, H AB 1008, I/A31 (17.01.11).

27 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 881, L 645, F 41, S 8, H AB 1008, I/A 30(17.09.10).

12 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ HERRAEZ ADORACION. Nombramientos. Secretario: MARTINEZ SANCHEZCONSUELO. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Reelecciones. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSEMANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 881, L 645, F 41, S 8, H AB 1008, I/A 29 (3.08.10).

24 de Diciembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 86.123,30 Euros. Resultante Suscrito: 6.545.851,60 Euros. Datos registrales. T 881, L 645, F 41, S8, H AB 1008, I/A 28 (15.12.09).

17 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA. Datos registrales. T 859, L 623, F 167, S 8, H AB 1008, I/A 27 (6.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n