Buscador CIF Logo

Actos BORME Corporacion Industrial Hispano-etiope Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Corporacion Industrial Hispano-etiope Sl

Actos BORME Corporacion Industrial Hispano-etiope Sl - B87282059

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Corporacion Industrial Hispano-etiope Sl con CIF B87282059

馃敊 Perfil de Corporacion Industrial Hispano-etiope Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Corporacion Industrial Hispano-etiope Sl

11 de Diciembre de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1009/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/06/2019. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID. Juez: DON JUAN CARLOS PICAZOMENENDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1009/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/06/2019. Auto deconclusi贸n del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID.Juez: DON JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ. Extinci贸n. Datos registrales. T 36282 , F 76, S 8, H M 602523, I/A 17 ( 2.12.19).

05 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABRIL HIJON JOSE MANUEL;MARTINEZ JIMENEZ EUGENIO;PINTO BERMUDEZ ALBERTO.Ampliaci贸n de capital. Capital: 74.996,00 Euros. Resultante Suscrito: 612.853,00 Euros. Datos registrales. T 36282 , F 74, S 8, HM 602523, I/A 16 (26.09.18).

29 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ESPINOS JIMENEZ MIGUEL. Datos registrales. T 36282 , F 74, S 8, H M 602523, I/A 15(19.01.18).

28 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Auditor: CODEX AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 36282 , F 74, S 8, H M 602523, I/A 14(19.12.17).

27 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN LORENZO MARIA CRISTINA. Nombramientos. Consejero: PINTO BERMUDEZALBERTO;TELLECHEA ROTA ALFREDO. Datos registrales. T 36282 , F 73, S 8, H M 602523, I/A 13 (16.11.17).

20 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN LORENZO MARIA CRISTINA. Nombramientos. Apo.Manc.: CAREAGA MOZO DE ROSALESIGNACIO. Datos registrales. T 36282 , F 73, S 8, H M 602523, I/A 12 (13.11.17).

14 de Noviembre de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR LA INSCRIPCION 12陋 DE FECHA 31/10/2017 DE OTORGAMIENTO Y REVOCACION DEPODER, DEBIENDO QUEDAR ANULADA. Datos registrales. T 33472 , F 203, S 8, H M 602523, I/A 12 (31.10.17).

08 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN LORENZO MARIA CRISTINA. Nombramientos. Apo.Manc.: CAREAGA MOZO DE ROSALESIGNACIO. Datos registrales. T 33472 , F 203, S 8, H M 602523, I/A 12 (31.10.17).

16 de Octubre de 2017
P谩gina web de la sociedad. Supresi贸n de la p谩gina web corporativa: www.eforealliance.com. Datos registrales. T 33472 , F 202, S8, H M 602523, I/A 11 ( 6.10.17).

08 de Septiembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SOPELANA, 11, OFICINA 107, URBANIZACION LA FLOR (MADRID). Datos registrales. T 33472 ,F 200, S 8, H M 602523, I/A 10 (31.08.17).

09 de Agosto de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 94.445,00 Euros. Resultante Suscrito: 537.857,00 Euros. Datos registrales. T 33472 , F 199, S 8, HM 602523, I/A 9 ( 1.08.17).

08 de Agosto de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 6陋 EL ACTO DE AMPLIACION DE CAPITAL, SIENDO ELCORRECTO: SUSCRITO DEL ACTO 41.750E Y SUSCRITO RESULTANTE 443.412E. Datos registrales. T 33472 , F 196, S 8, H M602523, I/A 6 (17.07.17).

31 de Julio de 2017
Nombramientos. Auditor: CODEX AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 33472 , F 199, S 8, H M 602523, I/A 8(21.07.17).

27 de Julio de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: PI脩AR DE JESUS PEDRO;PAZO FREIRE JULIO;MARTIN LORENZO MARIA CRISTINA;ABRIL HIJONJOSE MANUEL;ARENAS RUIZ-TAPIADOR JOSE EMILIO. Datos registrales. T 33472 , F 197, S 8, H M 602523, I/A 7 (17.07.17).

Ceses/Dimisiones. Secretario: ORTIZ ORTEGA MARTA LUISA. Consejero: ABRIL HIJON JOSE MANUEL. Vicepresid.: ABRILHIJON JOSE MANUEL. Consejero: ABRIL URIAS PATRICIA;PINTO BERMUDEZ ALBERTO;BIRHANU MOTUMA FIKRU.Cons.Del.Man: ABRIL HIJON JOSE MANUEL;PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Consejero: DE MIGUEL FERNANDEZ CESAR.Presidente: ARTI脩ANO DEL RIO PABLO. Cons.Del.Man: ARTI脩ANO DEL RIO PABLO;ORTIZ ORTEGA MARTA LUISA. Consejero:ARTI脩ANO DEL RIO PABLO;ORTIZ ORTEGA MARTA LUISA. Cons.Del.Man: PAZO FREIRE JULIO. Nombramientos. Consejero:ARENAS RUIZ-TAPIADOR JOSE EMILIO. VsecrNoConsj: ESPINOS JIMENEZ MIGUEL. Presidente: PI脩AR DE JESUS PEDRO.Secretario: ARENAS RUIZ-TAPIADOR JOSE EMILIO. Consejero: CAREAGA MOZO DE ROSALES IGNACIO;ABRIL HIJON JOSEMANUEL;MARTINEZ JIMENEZ EUGENIO Ampliaci贸n de capital. Capital: 41.475,00 Euros. Resultante Suscrito: 443.137,00 Euros.Datos registrales. T 33472 , F 196, S 8, H M 602523, I/A 6 (17.07.17).

28 de Diciembre de 2016
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.eforealliance.com. Datos registrales. T 33472 , F 196, S8, H M 602523, I/A 5 (19.12.16).

04 de Octubre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 177.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 401.662,00 Euros. Datos registrales. T 33472 , F 195, S 8,H M 602523, I/A 4 (26.09.16).

12 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 46.662,00 Euros. Resultante Suscrito: 224.662,00 Euros. Datos registrales. T 33472 , F 194, S 8, HM 602523, I/A 3 ( 4.02.16).

04 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Cons.Del.Man: PAZO FREIRE JULIO. Consejero: PI脩AR DE JESUS PEDRO;MARTIN LORENZO MARIACRISTINA;DE MIGUEL FERNANDEZ CESAR. Ampliaci贸n de capital. Capital: 169.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 178.000,00Euros. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 23潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONSECUENCIA DEMODIFICAR EL NUMERO MINIMO Y MAXIMO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 5/11.. Datos registrales. T33472 , F 193, S 8, H M 602523, I/A 2 (27.08.15).

10 de Junio de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.05.15. Objeto social: LA PROMOCION DE LA INVERSION ESPA脩OLA EN ETIOPIA ASICOMO LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS O PRESTADOS EN CADA UNO DE ESTOS PAISES.Domicilio: C/ PRINCIPE DE VERGARA 36 1潞 - IZQUIERDA (MADRID). Capital: 8.750,00 Euros. Nombramientos. Consejero:ARTI脩ANO DEL RIO PABLO. Presidente: ARTI脩ANO DEL RIO PABLO. Consejero: ABRIL HIJON JOSE MANUEL. Vicepresid.: ABRILHIJON JOSE MANUEL. Consejero: ORTIZ ORTEGA MARTA LUISA. Secretario: ORTIZ ORTEGA MARTA LUISA. Consejero: PAZOFREIRE JULIO;ABRIL URIAS PATRICIA;PINTO BERMUDEZ ALBERTO;BIRHANU MOTUMA FIKRU. Cons.Del.Man: ARTI脩ANO DELRIO PABLO;ABRIL HIJON JOSE MANUEL;ORTIZ ORTEGA MARTA LUISA;PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Datos registrales. T33472 , F 190, S 8, H M 602523, I/A 1 ( 1.06.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n