Actos BORME de Corporacion Masdenmach Sl
31 de Mayo de 2022Revocaciones. SECRETARIO: NAVARRO GONZALEZ CARLOS. CONS. DELEG.: NAVARRO GONZALEZ PABLO.VICEPRESIDEN: NAVARRO GONZALEZ PABLO. Nombramientos. CONSEJERO: GONZALEZ MESTRE PILAR. SECRETARIO:NAVARRO GONZALEZ CRISTINA. CONS.DEL.SOL: NAVARRO GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 43885 , F 122, S 8, H B253327, I/A 10 (23.05.22).
17 de Febrero de 2022Cambio de domicilio social. VIA AUGUSTA NUM.2 BIS P.5 (BARCELONA). Datos registrales. T 43885 , F 122, S 8, H B 253327,I/A 9 ( 9.02.22).
14 de Septiembre de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 240.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.427.480,00 Euros. Datos registrales. T 43885 ,F 121, S 8, H B 253327, I/A 8 ( 3.09.21).
23 de Febrero de 2021Revocaciones. CONSEJERO: GONZALEZ MESTRE MARIA PILAR. Nombramientos. VICEPRESIDEN: NAVARRO GONZALEZPABLO. Datos registrales. T 43885 , F 121, S 8, H B 253327, I/A 7 (15.02.21).
10 de Enero de 2014Modificaciones estatutarias. ART.17.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 43885 , F 121, S 8, H B 253327, I/A 6 (30.12.13).
23 de Agosto de 2013Revocaciones. CONS.DEL.MAN: NAVARRO GONZALEZ PABLO;NAVARRO GONZALEZ CARLOS. Nombramientos. CONS.DELEG.: NAVARRO GONZALEZ PABLO. Modificaciones estatutarias. ART.17.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 34883 , F 58, S 8, H B 253327, I/A 5 (16.08.13).