Buscador CIF Logo

Actos BORME Corprega Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Corprega Sa

Actos BORME Corprega Sa - A36879096

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Corprega Sa con CIF A36879096

馃敊 Perfil de Corprega Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Corprega Sa

13 de Septiembre de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 670.346,53 Euros. Resultante Suscrito: 1.871.893,47 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 92.325,47 Euros. Resultante Suscrito: 1.779.568,00 Euros. Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 8潞 y 9潞de los Estatutos Sociales, referentes al r茅gimen de transmisi贸n de las acciones. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 225, S 8, H PO27759, I/A 21 ( 5.09.22).

25 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Secretario: HERNANDEZ CARIDE MANUEL ALBERTO. Cancelaciones de oficio de nombramientos.Consejero: SANTORIO RODRIGUEZ ANGEL;BAHILLO PARADA FRANCISCO. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZTORRES SALVADOR. Consejero: BARCON PAJUELO PABLO;LLOPIZ PEREIRO FERNANDO LUIS. Reelecciones. Consejero:HERNANDEZ CARIDE MANUEL ALBERTO;LLOPIZ PEREIRO JOSE AGUSTIN;FERNANDEZ LOPEZ IGNACIO;ROMAN CARRERAANTONIO;FERNANDEZ TORRES SALVADOR;ABALDE VILLAR MIGUEL. Presidente: ABALDE VILLAR MIGUEL. Datos registrales.T 2589, L 2589, F 224, S 8, H PO 27759, I/A 19 (16.11.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMAN CARRERA ANTONIO;ABALDE VILLAR MIGUEL;HERNANDEZ CARIDE MANUEL ALBERTO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABALDE VILLAR MIGUEL;FERNANDEZ TORRES SALVADOR;LLOPIZ PEREIRO JOSE AGUSTIN.Datos registrales. T 2589, L 2589, F 224, S 8, H PO 27759, I/A 20 (17.11.20).

14 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: BAHILLO PARADA FRANCISCO. Secretario: ABALDE VILLAR MIGUEL. Nombramientos.Consejero: HERNANDEZ CARIDE MANUEL ALBERTO;LLOPIZ PEREIRO JOSE AGUSTIN. Presidente: ABALDE VILLAR MIGUEL.Secretario: HERNANDEZ CARIDE MANUEL ALBERTO. Otros conceptos: La Junta acuerda MODIFICAR el r茅gimen de transmisi贸nde las acciones y consecuente modificaci贸n de los art铆culos 8 y 9 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Datos registrales. T 2589,L 2589, F 223, S 8, H PO 27759, I/A 18 ( 4.12.17).

29 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMAN CARRERA JOSE;MALAXECHEVARRIA GROBAS DOMINGO FRANCISCO. Presidente:ROMAN CARRERA JOSE. Secretario: MALAXECHEVARRIA GROBAS DOMINGO FRANCISCO. Nombramientos. Presidente:BAHILLO PARADA FRANCISCO. Secretario: ABALDE VILLAR MIGUEL. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 223, S 8, H PO 27759,I/A 17 (20.03.17).

26 de Octubre de 2016
Reelecciones. Consejero: ROMAN CARRERA JOSE. Presidente: ROMAN CARRERA JOSE. Consejero: MALAXECHEVARRIAGROBAS DOMINGO FRANCISCO. Secretario: MALAXECHEVARRIA GROBAS DOMINGO FRANCISCO. Consejero: SANTORIORODRIGUEZ ANGEL;FERNANDEZ LOPEZ IGNACIO;ABALDE VILLAR MIGUEL;ROMAN CARRERA ANTONIO;BAHILLO PARADAFRANCISCO;FERNANDEZ TORRES SALVADOR. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 222, S 8, H PO 27759, I/A 16 (17.10.16).

15 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARCON GALLARDO LUIS GUILLERMO. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 222, S 8, H PO27759, I/A 15 ( 9.12.14).

11 de Noviembre de 2013
Cambio de domicilio social. C/ ESTORNINO 6 BAJO B (VIGO). Datos registrales. T 2589, L 2589, F 222, S 8, H PO 27759, I/A 14(31.10.13).

14 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOIS VAZQUEZ ERMITAS;ABALDE VILLAR MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABALDEVILLAR MIGUEL;HERNANDEZ CARIDE MANUEL ALBERTO;ROMAN CARRERA ANTONIO. Datos registrales. T 2589, L 2589, F221, S 8, H PO 27759, I/A 13 ( 7.02.13).

13 de Agosto de 2012
Reelecciones. Consejero: SANTORIO RODRIGUEZ ANGEL;ROMAN CARRERA JOSE;FERNANDEZ LOPEZIGNACIO;MALAXECHEVARRIA GROBAS DOMINGO FRANCISCO;BARCON GALLARDO LUIS GUILLERMO;ABALDE VILLARMIGUEL;ROMAN CARRERA ANTONIO;BAHILLO PARADA FRANCISCO;FERNANDEZ TORRES SALVADOR. Secretario:MALAXECHEVARRIA GROBAS DOMINGO FRANCISCO. Presidente: ROMAN CARRERA JOSE. Datos registrales. T 2589, L 2589,F 221, S 8, H PO 27759, I/A 12 ( 1.08.12).

20 de Octubre de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERGAL SA. GADINPRO SA. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 220, S 8, HPO 27759, I/A 11 ( 7.10.11).

03 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FERNANDEZ LOPEZ IGNACIO;SANTORIO RODRIGUEZ ANGEL. Presidente: SANTORIORODRIGUEZ ANGEL. Nombramientos. Presidente: ROMAN CARRERA JOSE. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 220, S 8, HPO 27759, I/A 10 (21.01.10).

15 de Diciembre de 2009
Cambio de domicilio social. PQUE TECNOLOGICO Y LOGISTICO DE VIGO RUA B S/N - P (VIGO). Datos registrales. T 2589, L2589, F 218, S 8, H PO 27759, I/A 8 ( 1.12.09).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ PEREIRO ENRIQUE;PEREIRO TABOADA EMILIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABALDEVILLAR MIGUEL;LOIS VAZQUEZ ERMITAS. Datos registrales. T 2589, L 2589, F 219, S 8, H PO 27759, I/A 9 ( 1.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n