Actos BORME de Costasol De Hipermercados Sl
24 de Noviembre de 2023Nombramientos. Presidente: MARTIN SIMON AURELIO. Vicepresid.: CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T5790, L 4697, F 9, S 8, H MA 30367, I/A 70 (17.11.23).
10 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Secretario: PEREZ DE VARGAS RUEDAS JAVIER. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 9, S 8, H MA 30367,I/A 68 A ( 2.11.23).
30 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO GUI脩ON DANIEL;PEREZ DE VARGAS RUEDAS JAVIER. Nombramientos.SecreNoConsj: PEREZ DE VARGAS RUEDAS JAVIER. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 9, S 8, H MA 30367, I/A 68 (19.10.23).
Nombramientos. Consejero: MARTIN SIMON AURELIO;RUIZ MARQUEZ INES MARIA;MARTIN RUIZ AURELIO;MARTIN RUIZJAVIER;CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 9, S 8, H MA 30367, I/A 69 (20.10.23).
26 de Julio de 2023Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: MARTIN SIMON AURELIO. Consejero: MARTIN SIMONAURELIO;MARTIN RUIZ AURELIO;MARTIN RUIZ JAVIER;RUIZ MARQUEZ INES MARIA. Otros conceptos: Se hace constar lacancelaci贸n del los siguientes miembros del consejo por caducidad del mismo, conforme al art铆culo 145.3 RRM: DON LUIS DOMINGOCERRO GIRALDEZ en ins. 51 y 54; DON AURELIO MARTIN RUIZ, DON JAVIER MARTIN RUIZ, DO脩A INES MARIA RUIZMARQUEZ Y DON AURELIO MARTIN SIMON en ins. 56.- Datos registrales. T 5189, L 4096, F 71, S 8, H MA 30367, I/A 56 a(20.07.23).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T 5189, L 4096,F 70, S 8, H MA 30367, I/A 51 a (20.07.23).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Vicepresid.: CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T 5189, L 4096,F 71, S 8, H MA 30367, I/A 54 a (20.07.23).
01 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: TORRES MORA JOSE MANUEL. Nombramientos. Secretario: PEREZ DE VARGAS RUEDASJAVIER. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 8, S 8, H MA 30367, I/A 67 (24.01.23).
20 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ ARROYO JOSE SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: COBO BALLESTEROSIGNACIO LUIS. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 8, S 8, H MA 30367, I/A 66 (10.05.22).
09 de Septiembre de 2021Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 8, S 8, H MA 30367, I/A 65 (30.08.21).
14 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MURCIANO DAVID. Nombramientos. Consejero: ROMERO GUI脩ON DANIEL. Datos registrales.T 5790, L 4697, F 8, S 8, H MA 30367, I/A 64 ( 3.06.21).
04 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 8, S 8, H MA 30367, I/A 63 (22.07.20).
24 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN SIMON AURELIO;MARTIN RUIZ AURELIO;MARTIN RUIZ JAVIER;SANCHEZ ORTIZFRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 7, S 8, H MA 30367, I/A 62 (15.01.20).
09 de Septiembre de 2019Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ ARROYO JOSE SANTIAGO;HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON. Datos registrales.T 5790, L 4697, F 7, S 8, H MA 30367, I/A 61 (29.08.19).
31 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN SIMON AURELIO;MARTIN RUIZ AURELIO;MARTIN RUIZ JAVIER;PEREZ DE VARGASRUEDAS JAVIER. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 7, S 8, H MA 30367, I/A 60 (23.07.19).
18 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5790, L 4697, F 7, S 8, H MA 30367, I/A 59 (10.07.19).
18 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN RUIZ AURELIO;MARTIN RUIZ JAVIER. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 71, S 8, HMA 30367, I/A 58 ( 5.12.18).
22 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DE VARGAS LOPEZ IGNACIO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: PEREZ DEVARGAS RUEDAS JAVIER. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 71, S 8, H MA 30367, I/A 57 (13.11.18).
10 de Octubre de 2018Reelecciones. Presidente: MARTIN SIMON AURELIO. Consejero: RUIZ MARQUEZ INES MARIA;MARTIN SIMON AURELIO;PEREZDE VARGAS LOPEZ IGNACIO FRANCISCO;MARTIN RUIZ AURELIO;MARTIN RUIZ JAVIER. Datos registrales. T 5189, L 4096, F71, S 8, H MA 30367, I/A 56 ( 1.10.18).
21 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 71, S 8, H MA 30367, I/A 55 ( 9.08.18).
18 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: YBARRA LORING JORGE. Nombramientos. Apoderado: CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datosregistrales. T 5189, L 4096, F 70, S 8, H MA 30367, I/A 53 ( 9.05.18).
Nombramientos. Vicepresid.: CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 70, S 8, H MA 30367, I/A54 ( 9.05.18).
30 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ CALVET FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: MURCIANO DAVID. Datosregistrales. T 5189, L 4096, F 70, S 8, H MA 30367, I/A 52 (20.04.18).
17 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: YBARRA LORING JORGE. Vicepresid.: YBARRA LORING JORGE. Nombramientos. Consejero:CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 70, S 8, H MA 30367, I/A 51 ( 5.04.18).
10 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 70, S 8, H MA 30367, I/A 50 ( 1.08.17).
07 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 69, S 8, H MA 30367, I/A 49 (29.08.16).
21 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: RAMOS VARILLAS AGUSTIN. Apo.Manc.: RAMOS VARILLAS AGUSTIN;RAMOS VARILLAS AGUSTIN.Datos registrales. T 5189, L 4096, F 69, S 8, H MA 30367, I/A 48 (10.03.16).
11 de Febrero de 2016Nombramientos. Vicepresid.: YBARRA LORING JORGE. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 70, S 8, H MA 30367, I/A 47 (3.02.16).
16 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MADRILLEY SANCHEZ CARLOS;AYLLON RODRIGUEZ EVANGELINA;LOPEZ RIUS CRISTINA.Apoderado: NU脩EZ PASCUAL SERGIO. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN JIMENEZ MARIA ELENA;YBARRA LORING JORGE.Datos registrales. T 5189, L 4096, F 69, S 8, H MA 30367, I/A 46 ( 3.12.15).
17 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS VARILLAS AGUSTIN. Vicepresid.: RAMOS VARILLAS AGUSTIN. Nombramientos.Consejero: LOPEZ CALVET FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 68, S 8, H MA 30367, I/A 45 ( 9.11.15).
13 de Octubre de 2015Cambio de objeto social. : a) El comercio al por mayor y al por menor de toda clase de mercanc铆as, productos y servicios de licitocomercio, incluyendo los actos necesarios para su venta, adquisici贸n, importaci贸n y exportaci贸n, , en particular, la explotaci贸n dehipermercados, supermercados y otros establecimientos de venta. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 68, S 8, H MA 30367, I/A 43 (2.10.15).
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 68, S 8, H MA 30367, I/A 44 ( 2.10.15).
14 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ SANCHEZ MONICA;SORIANO VILLAR LUCIA. Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZRODRIGUEZ JUAN RAMON;NU脩EZ PASCUAL SERGIO. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 68, S 8, H MA 30367, I/A 42 (4.11.14).
29 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ PEREZ JOSE LUIS;LOPEZ ORTIZ-VILLAJOS JAIME. Nombramientos. Consejero:GUTIERREZ ARROYO JOSE SANTIAGO;HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 67, S 8,H MA 30367, I/A 41 (21.10.14).
31 de Diciembre de 2013Modificaciones estatutarias. 16bis. Reglas adicionales de asistencia a las reuniones del consejo de administraci贸n.-. Datosregistrales. T 5189, L 4096, F 67, S 8, H MA 30367, I/A 30 (20.12.13).
16 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: MORENO ROBERT PABLO. Apo.Manc.: MORENO ROBERT PABLO;MERRY DEL VAL GRACIEALFONSO;LEYVA ESTEBANEZ JAIME;MORENO ROBERT PABLO;DE FRANCISCO BLANCO JOSE ANTONIO;VARA IZQUIERDOJOSE MARIA;DELICADO ESCUDERO FERNANDO. Apo.Sol.: DOCAMPO BLANQUEZ VICENTE;GAYTAN DE AYALA CREIXELLIGNACIO;PEREZ DE HERRASTI PELLON JOSE MARIA;GAVILAN BEJINES RAFAEL;JACINTO MARIN CARLOS. Apoderado:LUQUE ALBALA JOAQUIN JESUS. Datos registrales. T 5189, L 4096, F 67, S 8, H MA 30367, I/A 39 (29.11.13).
17 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MAZARIEGOS LUELMO JUAN. Nombramientos. Consejero: LOPEZ ORTIZ-VILLAJOS JAIME.Reelecciones. Presidente: MARTIN SIMON AURELIO. Vicepresid.: RAMOS VARILLAS AGUSTIN. Consejero: RUIZ MARQUEZ INESMARIA;MARTIN SIMON AURELIO;PEREZ DE VARGAS LOPEZ IGNACIO FRANCISCO;RAMOS VARILLAS AGUSTIN;MARTIN RUIZAURELIO;MARTIN RUIZ JAVIER. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 152, S 8, H MA 30367, I/A 38 ( 9.10.13).
08 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ LLANO ALFONSO. Nombramientos. SecreNoConsj: TORRES MORA JOSE MANUEL.Datos registrales. T 4151, L 3061, F 152, S 8, H MA 30367, I/A 36 (30.07.13).
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MORAL BETERE CRISTINA. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 152, S 8, H MA 30367, I/A 37(30.07.13).
01 de Marzo de 2013Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4151,L 3061, F 152, S 8, H MA 30367, I/A 35 (21.02.13).
31 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DELGADO MARQUEZ PEDRO. Nombramientos. Consejero: YBARRA LORING JORGE. Datosregistrales. T 4151, L 3061, F 152, S 8, H MA 30367, I/A 34 (23.01.13).
23 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 151, S 8, H MA 30367, I/A 33 ( 9.08.12).
10 de Abril de 2012Modificaciones estatutarias. Retribuci贸n del consejo de administraci贸n.. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 151, S 8, H MA30367, I/A 32 (26.03.12).
20 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO;RODRIGUEZ VILLAR LUIS. Nombramientos. Consejero:GUTIERREZ PEREZ JOSE LUIS;MAZARIEGOS LUELMO JUAN. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 151, S 8, H MA 30367, I/A 31( 8.02.12).
23 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 151, S 8, H MA 30367, I/A 30 (10.08.11).
13 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTIN RUIZ JAVIER. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 150, S 8, H MA 30367, I/A 29 (26.08.10).
11 de Agosto de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 150, S 8, H MA 30367, I/A 28 (27.07.10).
26 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4151, L 3061, F 150, S 8, H MA 30367, I/A 27 (14.08.09).