Buscador CIF Logo

Actos BORME Coto De Castilleja Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Coto De Castilleja Sa

Actos BORME Coto De Castilleja Sa - A78317864

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Coto De Castilleja Sa con CIF A78317864

馃敊 Perfil de Coto De Castilleja Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Coto De Castilleja Sa

20 de Septiembre de 2022
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VARELA ORTEGA JOSE. Datos registrales. T 32401 , F 207, S 8,H M 58665, I/A 27 (13.09.22).

14 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SALA SILVEIRA LUCIA. Nombramientos. Adm. Unico: VARELA ORTEGA JOSE. Datosregistrales. T 32401 , F 207, S 8, H M 58665, I/A 26 ( 7.06.22).

26 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LAMBAS JESUS. Presidente: SANCHEZ LAMBAS JESUS. Consejero: SPOTTORNOROBLES MIGUEL. Cons.Del.Sol: SPOTTORNO ROBLES MIGUEL. Consejero: DE LA VEGA CA脩IZARES CARMEN;FERNANDEZGONZALEZ NANCY. Secretario: SPOTTORNO ROBLES MIGUEL. Nombramientos. Adm. Unico: SALA SILVEIRA LUCIA.Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 6, 10, 11, 13, 14, 21 y 26 de los estatutos sociales. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 32401 , F 206, S 8, HM 58665, I/A 25 (18.06.18).

16 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DE LA VEGA CA脩IZARES CARMEN. Datos registrales. T 32401 , F 205, S 8, H M 58665, I/A 24( 9.04.15).

14 de Abril de 2015
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 21 EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE NACYFERNANDEZ GONZALEZ SIENDO LO CORRECTO NANCY FERNANDEZ GONZALEZ. Datos registrales. T 3470 , F 225, S 8, H M58665, I/A 21 (17.06.14).

Otros conceptos: SUBSANACION DEL NUMERO DEL D.N.I. DE LA CONSEJERA DO脩A CARMEN DE LA VEGA CA脩IZARES,SIENDO EL NUMERO CORRECTO EL: 00806523-M. Datos registrales. T 32401 , F 205, S 8, H M 58665, I/A 23 ( 6.04.15).

30 de Junio de 2014
Cambio de domicilio social. C/ FORTUNY 53 - EDIFICIO PRINCIPAL, PRIMERA PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 32401 ,F 205, S 8, H M 58665, I/A 22 (20.06.14).

26 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LAMBAS JESUS;PEREZ DE ARMI脩AN Y DE LA SERNA ALFREDO;SETLOR SL.Presidente: SANCHEZ LAMBAS JESUS. Secretario: PEREZ DE ARMI脩AN Y DE LA SERNA ALFREDO. Con.Delegado: SETLOR SL.Representan: GASSET LORING MANUEL. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ LAMBAS JESUS. Presidente: SANCHEZLAMBAS JESUS. Consejero: SPOTTORNO ROBLES MIGUEL. Cons.Del.Sol: SPOTTORNO ROBLES MIGUEL. Consejero: DE LAVEGA CA脩IZARES CARMEN. Cons.Del.Sol: DE LA VEGA CA脩IZARES CARMEN. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ NACY.Secretario: SPOTTORNO ROBLES MIGUEL. Datos registrales. T 3470 , F 225, S 8, H M 58665, I/A 21 (17.06.14).

28 de Abril de 2014
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARA脩ON. Datosregistrales. T 3470 , F 225, S 8, H M 58665, I/A 20 (14.04.14).

22 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS GASCON ANTONIO. Presidente: RAMOS GASCON ANTONIO. Consejero: SERRANOMARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Secretario: SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Consejero: SANCHO ROF JOSE.Cons.Del.Sol: SANCHO ROF JOSE;RAMOS GASCON ANTONIO;SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Nombramientos.Representan: GASSET LORING MANUEL. Consejero: SANCHEZ LAMBAS JESUS;PEREZ DE ARMI脩AN Y DE LA SERNAALFREDO;SETLOR SL. Presidente: SANCHEZ LAMBAS JESUS. Secretario: PEREZ DE ARMI脩AN Y DE LA SERNA ALFREDO.Con.Delegado: SETLOR SL. Datos registrales. T 3470 , F 224, S 8, H M 58665, I/A 19 (11.04.14).

20 de Diciembre de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 180.303,63 Euros. Resultante Suscrito: 180.303,63 Euros. Datos registrales. T 3470 , F222, S 8, H M 58665, I/A 18 (12.12.13).

05 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Liq: RAMOS GASCON ANTONIO;SANCHO ROF JOSE;SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL.Nombramientos. Consejero: RAMOS GASCON ANTONIO. Presidente: RAMOS GASCON ANTONIO. Consejero: SERRANOMARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Secretario: SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Consejero: SANCHO ROF JOSE.Cons.Del.Sol: SANCHO ROF JOSE;RAMOS GASCON ANTONIO;SERRANO MARTINEZ ESTELLEZ ANGEL. Reactivaci贸n de lasociedad (Art. 242 del Reglamento del Registro Mercantil). Datos registrales. T 3470 , F 222, S 8, H M 58665, I/A 17 (25.06.12).

30 de Junio de 2010
Otros conceptos: REQUERIMIENTO DE ANOTACION PREVENTIVA DE SOLICITUD DE ACTA NOTARIAL EN JUNTA ACELEBRAR EL 29 DE JUNIO DE 2010. Datos registrales. T 3470 , F 218, S 8, H M 58665, I/A 14 (18.06.10).

10 de Junio de 2010
Nombramientos. Auditor: MORON PORTO SANTIAGO. Datos registrales. T 3470 , F 218, S 8, H M 58665, I/A 13 (31.05.10).

16 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ PITA VICTOR;VARELA ORTEGA CONSUELO. Cons.Del.Sol: VARELA ORTEGACONSUELO. Secretario: PEREZ PITA VICTOR. Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ BAYO RAFAEL. Nombramientos. Consejero:PEREZ VARELA ISABEL LEONOR. Secretario: PEREZ VARELA ISABEL LEONOR. Consejero: PEREZ VARELA DANIEL. Datosregistrales. T 3470 , F 218, S 8, H M 58665, I/A 12 ( 5.02.10).

22 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apoderado: PEREZ PITA VICTOR. Datos registrales. T 3470 , F 217, S 8, H M 58665, I/A 11 ( 8.10.09).

10 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Representan: VARELA ORTEGA JOSE. Consejero: MEFAISTOS SL. Secretario: VARELA ORTEGACONSUELO. Nombramientos. Consejero: PEREZ PITA VICTOR. Secretario: PEREZ PITA VICTOR. Reelecciones. Representan:VARELA ORTEGA SOLEDAD. Consejero: VARELA ORTEGA CONSUELO;SABELUS SL. Presidente: SABELUS SL. Cons.Del.Sol:VARELA ORTEGA CONSUELO;SABELUS SL. Datos registrales. T 3470 , F 217, S 8, H M 58665, I/A 10 (26.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n