Actos BORME de Cotyp Sl
29 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ESTRADA MONIS MARIA DOLORES. Nombramientos. Apoderado: THIEBAUT ESTRADAMARIA DOLORES. Datos registrales. T 29527 , F 94, S 8, H M 97443, I/A 26 (21.12.16).
12 de Agosto de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Datos registrales. T 29527, F 91, S 8, H M 97443, I/A 25 ( 3.08.15).
08 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: THIEBAUT OLIVEIRA ALBERTO. Presidente: THIEBAUT OLIVEIRA ALBERTO. Vicepresid.:ESTRADA MONIS MARIA DOLORES. Nombramientos. Consejero: THIEBAUT ESTRADA RAFAEL RODRIGO. Presidente:ESTRADA MONIS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 29527 , F 91, S 8, H M 97443, I/A 24 (30.03.15).
18 de Abril de 2013Cambio de domicilio social. AVDA DE CONCHA ESPINA 8 - 4潞 DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 29527 , F 91, S 8, H M97443, I/A 23 (11.04.13).
22 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ESTRADA MONIS MARIA DOLORES. Nombramientos. Consejero: THIEBAUT OLIVEIRAALBERTO;ESTRADA MONIS MARIA DOLORES;THIEBAUT ESTRADA ALBERTO. Presidente: THIEBAUT OLIVEIRA ALBERTO.Vicepresid.: ESTRADA MONIS MARIA DOLORES. Cons.Del.Sol: THIEBAUT ESTRADA ALBERTO;ESTRADA MONIS MARIADOLORES. Secretario: THIEBAUT ESTRADA MARIA DOLORES. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. 17. Administraci贸n y Representacion.-. 20. Retribuci贸n.-. Datosregistrales. T 5957 , F 139, S 8, H M 97443, I/A 22 (13.02.12).
09 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: THIEBAUT OLIVEIRA ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: THIEBAUT OLIVEIRA ALBERTO.Datos registrales. T 5957 , F 138, S 8, H M 97443, I/A 21 (25.11.11).
10 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.894.352,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.032.582,00 Euros. Datos registrales. T 5957 , F 137, S8, H M 97443, I/A 20 ( 1.03.10).