Actos BORME de Coverclim Sociedad Anonima
31 de Agosto de 2012Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 5076 , F 116, S 8, H BI 48355, I/A 18 (21.08.12).
20 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: BUGALLO ARIAS ALFONSO. Datos registrales. T 5076 , F 116, S 8, H BI 48355, I/A 17 ( 2.03.12).
20 de Mayo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 61.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:61.000,00 Euros. Desembolsado: 61.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 61.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 61.000,00 Euros.Datos registrales. T 5076 , F 115, S 8, H BI 48355, I/A 16 (10.05.11).
03 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: JAUREGUI URRESTI XABIER;URIZAR SAN ILDEFONSO JUAN MANUEL;LECEA MIGUEL LUISJAVIER. Datos registrales. T 5076 , F 115, S 8, H BI 48355, I/A 15 (21.01.11).
29 de Noviembre de 2010Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ONDULINE INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA. Sociedad unipersonal. Cambiode identidad del socio 煤nico: ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONI. Datos registrales. T 5076 , F115, S 8, H BI 48355, I/A 14 (16.11.10).
10 de Junio de 2010Nombramientos. Secretario: BLAZQUEZ ANDRE. Datos registrales. T 5076 , F 114, S 8, H BI 48355, I/A 13 (28.05.10).
04 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTINEZ DE LA HIDALGA SUSO AMELIO. Consejero: GOMEZ LAKA ANA JOSE;MARTINEZDE LA HIDALGA SUSO AMELIO. Presidente: MARTINEZ DE LA HIDALGA SUSO AMELIO. Consejero: GOMEZ LACA GORKA.Secretario: GOMEZ LACA GORKA. Consejero: MARTINEZ DE LA HIDALGA CARDA脩O CARLOS ALVARO;MARTINEZ DE LAHIDALGA CARDA脩O TERESA. Con.Delegado: MARTINEZ DE LA HIDALGA CARDA脩O CARLOS ALVARO. Nombramientos.Consejero: NOEL FOUREL JEAN. Presidente: NOEL FOUREL JEAN. Consejero: BLAZQUEZ ANDRE. Vicepresid.: BLAZQUEZANDRE. Consejero: MARTINEZ DE LA HIDALGA CARDA脩O MARIA TERESA. Secretario: MARTINEZ DE LA HIDALGA CARDA脩OMARIA TERESA. Con.Delegado: BLAZQUEZ ANDRE. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 739.805,40 Euros. ResultanteSuscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 61.000,00 Euros. Desembolsado: 61.000,00 Euros. Resultante Suscrito:61.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 61.000,00 Euros. Datos registrales. T 5076 , F 111, S 8, H BI 48355, I/A 11 (17.05.10).
28 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ DE LA HIDALGA CARDA脩O MARIA TERESA. Consejero: MARTINEZ DE LA HIDALGACARDA脩O MARIA TERESA. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Consejero: REBOIS ANTOINE. Datos registrales. T 5076 , F 113, S 8, H BI 48355, I/A 12 (17.05.10).
06 de Mayo de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: JAUREGUI URRESTI XABIER;URIZAR SAN ILDEFONSO JUAN MANUEL;LECEA MIGUEL LUISJAVIER. Datos registrales. T 5076 , F 110, S 8, H BI 48355, I/A 9 (20.04.10).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ DE LA HIDALGA CARDA脩O MARIA TERESA;GOMEZ LACA GORKA. Apo.Manc.:JAUREGUI URRESTI XABIER;URIZAR SAN ILDEFONSO JUAN MANUEL;DE LA SOTA GALDIZ DOMINGO. Datos registrales. T5076 , F 111, S 8, H BI 48355, I/A 10 (20.04.10).
13 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: JAUREGUI URRESTI XABIER;URIZAR SAN ILDEFONSO JUAN MANUEL;DE LA SOTA GALDIZDOMINGO. Datos registrales. T 4800 , F 50, S 8, H BI 48355, I/A 8 ( 2.11.09).
11 de Febrero de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 930.020,00 Euros. Desembolsado: 930.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.740.020,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.740.020,00 Euros. Datos registrales. T 4800 , F 48, S 8, H BI 48355, I/A 6 (29.01.09).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.000.214,60 Euros. Resultante Suscrito: 739.805,40 Euros. Datos registrales. T 4800 , F49, S 8, H BI 48355, I/A 7 (30.01.09).