Actos BORME de Cresia Directorship Sl
22 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PENTREATHNICHOLAS;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;DE LA SERNA GOULD LUIS JAIME;TIELVE MARTINEZ DE GUERE脩UBEATRIZ;LACACI NUEVO FERNANDO;MOLINARI MIRKO PIETRO EMILIO;MOLINA DEL VALLE ELENA;RIBALLO FERNANDEZANTONIO ENRIQUE;MOYA TRIGUERO FRANCISCO. Datos registrales. T 41831 , F 41, S 8, H M 668432, I/A 12 (13.04.22).
05 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T 37498 , F 94, S 8, H M 668432, I/A 11(27.04.21).
29 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 37498 , F 92, S 8, H M 668432, I/A 10(22.04.21).
07 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: LACACI NUEVO FERNANDO. Apo.Sol.: RIBALLO FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE;MARTINEZNAVARRO MARIA ARANZAZU;PARDO AYUSO JOSE ENRIQUE. Apo.Man.Soli: MICO VALDENEBRO FERNANDO;DIAZ ALMAZANDAVID ANTONIO;DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIMEApo.Manc.: PARADISO BENIAMINO;TIELVE MARTINEZ DE GUERE脩UBEATRIZ. Datos registrales. T 37498 , F 90, S 8, H M 668432, I/A 7 (30.09.20).
Revocaciones. Apoderado: PARADISO BENIAMINO. Apo.Manc.: PARADISO BENIAMINO. Datos registrales. T 37498 , F 92, S 8,H M 668432, I/A 8 (30.09.20).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MICO VALDENEBRO FERNANDO. Datos registrales. T 37498 , F 92, S 8, H M 668432, I/A 9(30.09.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS.Datos registrales. T 37498 , F 89, S 8, H M 668432, I/A 6 (23.04.20).
27 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ POETA JOAN MARAGALL N潞 1, 5陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 37498 , F 89, S 8, HM 668432, I/A 5 (20.04.20).
03 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;PARDO AYUSO JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T 37498 , F 88, S 8, H M668432, I/A 4 (27.05.19).
28 de Diciembre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: X-ELIO ENERGY SL. Datos registrales. T 37498 , F 87, S 8, H M 668432, I/A 3(19.12.18).
27 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: X-ELIO ENERGY SL. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 2.- . Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 4.- . Cambio de domicilio social. C/ OMBU 3 2陋(MADRID). Cambio de objeto social. a) El desarrollo de proyectos de energ铆as renovables, principalmente de energ铆a solarfotovolt谩ica, en cualquiera de sus fases, desde a promoci贸n de proyectos hasta la explotaci贸n de parques y plantas. b) La fabricaci贸n,comercializaci贸n... Datos registrales. T 37498 , F 86, S 8, H M 668432, I/A 2 (18.12.18).
04 de Mayo de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.04.18. Objeto social: a) El asesoramiento y consultor铆a en general de toda clase deempresas, especialmente en los campos fiscal, contable, laboral, econ贸mico, multimedia, internet, servicios, en cuyo caso la sociedadactuar谩 como sociedad de medios o de intermediaci贸n.- b) La actividad inmobiliaria y la urbanizaci贸n, co. Domicilio: C/ MONTEESQUINZA 30 BAJO IZ (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL.Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datos registrales. T 37498 , F 84, S 8, H M 668432, I/A 1 (25.04.18).