Buscador CIF Logo

Actos BORME Crisnova Vidrio Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Crisnova Vidrio Sociedad Anonima

Actos BORME Crisnova Vidrio Sociedad Anonima - A02057032

Tenemos registrados 42 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Crisnova Vidrio Sociedad Anonima con CIF A02057032

🔙 Perfil de Crisnova Vidrio Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Crisnova Vidrio Sociedad Anonima

23 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1025, L 789, F 217, S 8, H AB 1340, I/A 96(16.11.23).

18 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ ORTEGA JOSE MARIA. Datos registrales. T 1025, L 789, F 215, S 8, H AB 1340, I/A 95 (9.08.22).

22 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER. Apo.Sol.: ARBERAS TORDABLEJAVIER;BENGOECHEA OCIO JESUS;VALLEJO MOSLARES JESUS;ITURBE ACHA ENRIQUE. Apo.Man.Soli: QUILEZ SAEZ JOSEANDRES;RUBIO RENESES JULIO;ALBERTO SANGRONIZ LUIS;GARAU PERELLO NADAL. Apo.Sol.: MARTIN GARCIAOLGA;MARTIN GARCIA OLGA;TOLOSA SAEZ VICTOR;BENGOECHEA OCIO JESUS. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUISALBERTO;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Apoderado: URIBE ECHEVARRIA ANZA JOSE RAMON. Datos registrales. T1025, L 789, F 215, S 8, H AB 1340, I/A 94 (14.06.21).

15 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;CASADO CASUSO MARCOS. Datos registrales. T 1001, L765, F 10, S 8, H AB 1340, I/A 93 ( 8.01.21).

26 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1001, L 765, F 10, S 8, H AB 1340, I/A 92(19.11.20).

09 de Julio de 2020
Reelecciones. Presidente: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Consejero: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Secretario: GOMEZMERINO RAUL. Consejero: GOMEZ MERINO RAUL;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1001, L 765, F 9, S 8, H AB1340, I/A 91 ( 2.07.20).

04 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: ECHAGUE LACABE BELEN. Datos registrales. T 1001, L 765, F 9, S 8, H AB 1340, I/A 90 (28.01.20).

03 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINO RAUL. Apo.Manc.: GUERRA PAULO;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DEMATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 988, L 752, F 136, S 8, H AB1340, I/A 76 (24.12.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOLOSA SAEZ VICTOR;BENGOECHEA OCIO JESUS;ITURBE ACHA ENRIQUE;DE ANDRADEGUERRA PAULO GHILHERME. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA OLGA;LOPEZ LABURU ANA. Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINO RAUL.Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;SCHMITT ZALBIDE JORGE.Apo.Man.Soli: ROLDAN MAIZ ANGEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;RUIZ ARAUZOMARKEL;ANDRES QUILEZ JOSE;ECHAGUE LACABE BELEN;GARATE GUTIERREZ ELENA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;GUERRA PAULO;FERNANDEZDE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Datos registrales. T 1000, L 764, F 205, S 8, H AB 1340, I/A 77 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRA PAULO. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DEMATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1000, L 764, F 211, S 8, HAB 1340, I/A 78 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Apo.Manc.: GOMEZ MERINORAUL;GUERRA PAULO;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1000, L 764, F 215, S 8,H AB 1340, I/A 79 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROLDAN MAIZ ANGEL. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;GUERRA PAULO;FERNANDEZ DEMENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T1000, L 764, F 219, S 8, H AB 1340, I/A 80 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;CASADO CASUSO MARCOS. Apo.Manc.: GOMEZ MERINORAUL;GUERRA PAULO;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITTZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1000, L 764, F 220, S 8, H AB 1340, I/A 81 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ ARAUZO MARKEL. Datos registrales. T 1000, L 764, F 221, S 8, H AB 1340, I/A 82 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: ECHAGUE LACABE BELEN. Datos registrales. T 1000, L 764, F 223, S 8, H AB 1340, I/A 83 (24.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: ARBEO BARRON GERARDO;MOYA SEGADO ORIOL. Datos registrales. T 1000, L 764, F 225, S 8, HAB 1340, I/A 84 (26.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARATE GUTIERREZ ELENA. Datos registrales. T 1000, L 764, F 225, S 8, H AB 1340, I/A 85(26.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA OLGA. Datos registrales. T 1001, L 765, F 4, S 8, H AB 1340, I/A 86 (26.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: ECHEVARRIA AYASTUY GORKA. Datos registrales. T 1001, L 765, F 5, S 8, H AB 1340, I/A 87(26.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: BENGOECHEA OCIO JESUS;TOLOSA SAEZ VICTOR. Datos registrales. T 1001, L 765, F 6, S 8, H AB1340, I/A 88 (26.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: QUILEZ SAEZ JOSE ANDRES. Datos registrales. T 1001, L 765, F 7, S 8, H AB 1340, I/A 89 (26.12.18).

04 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 977, L 741, F 194, S 8, H AB 1340, I/A 75(27.11.17).

16 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 977, L 741, F 194, S 8, H AB 1340, I/A 74 (8.08.17).

21 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: ECHAGUE LACABE BELEN;GARATE GUTIERREZ ELENA;MARTIN GARCIA OLGA. Datos registrales.T 940, L 704, F 112, S 8, H AB 1340, I/A 73 (14.12.16).

08 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Datos registrales. T 940, L 704, F 111,S 8, H AB 1340, I/A 72 (31.10.16).

11 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 940, L 704, F 111, S 8, H AB 1340, I/A 71 (4.08.16).

30 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ ARAUZO MARKEL;ANDRES QUILEZ JOSE. Datos registrales. T 936, L 700, F 145, S 8, H AB1340, I/A 70 (23.09.15).

09 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 936, L 700, F 145, S 8, H AB 1340, I/A 69 (2.10.14).

15 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Consejero: ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE EDUARDO;DELCLAUXMULLER LUIS;DELCLAUX DE LA SOTA RAMON;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;DELCLAUX ZULUETACARLOS;ERRANDONEA DELCLAUX ESTEBAN. Presidente: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Consejero: URIGUEN VILLALBAVIRGINIA;GUIBERT DELCLAUX RAFAEL;ADDVALIA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA;DELCLAUX ZUBIRIA ALVARO. Secretario:BERECIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON. Nombramientos. Consejero: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDEJORGE;GOMEZ MERINO RAUL. Presidente: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Secretario: GOMEZ MERINO RAUL. Datosregistrales. T 881, L 645, F 27, S 8, H AB 1340, I/A 68 ( 7.11.13).

02 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 881, L 645, F 27, S 8, H AB 1340, I/A 67(19.09.13).

05 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE NORONHA SANTOS GALLO VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 881, L 645, F 27, S 8, HAB 1340, I/A 65 (29.07.13).

Reelecciones. Consejero: GUIBERT DELCLAUX RAFAEL;ADDVALIA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 881, L645, F 27, S 8, H AB 1340, I/A 66 (29.07.13).

27 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 881, L 645, F 274, S 8, H AB 1340, I/A 64(17.08.12).

21 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA. Apo.Manc.: DE SANTIAGO LOPEZ DEURALDE FERNANDO MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Datosregistrales. T 881, L 645, F 26, S 8, H AB 1340, I/A 64 (10.08.12).

10 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 881, L 645, F 26, S 8, H AB 1340, I/A 62 (1.08.11).

28 de Julio de 2011
Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER. Reelecciones. Consejero: DELCLAUX ZULUETACARLOS;ERRANDONEA DELCLAUX ESTEBAN. Presidente: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Consejero: URIGUEN VILLALBAVIRGINIA. Datos registrales. T 881, L 645, F 25, S 8, H AB 1340, I/A 61 (18.07.11).

11 de Abril de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LAS FUENTES INCHAUSTI JON ANDER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINORAUL. Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;SCHMITT ZALBIDEJORGE;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA. Apo.Man.Soli: ROLDAN MAIZ ANGEL. Datos registrales. T 819, L583, F 132, S 8, H AB 1340, I/A 60 ( 1.04.11).

01 de Septiembre de 2010
Reelecciones. Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA RAMON. Datos registrales. T 819, L 583, F 132, S 8, H AB 1340, I/A 58(23.08.10).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 819, L 583, F 132, S 8, H AB 1340, I/A 59(23.08.10).

27 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ PEÑAFIEL JESUS MARIA;URIBE ECHEVARRIA ANZA JOSE RAMON. Apo.Sol.: DE LACHA YOTAÑES ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOLOSA SAEZ VICTOR;BENGOECHEA OCIO JESUS;ITURBE ACHAENRIQUE;DE ANDRADE GUERRA PAULO GHILHERME. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA OLGA;LOPEZ LABURU ANA. Datos

10 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 819, L 583, F 130, S 8, H AB 1340, I/A 56(30.11.09).

03 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: IRAZABAL PEREZ JOSE ANGEL. Vicesecret.: IRAZABAL PEREZ JOSE ANGEL. Reelecciones.Consejero: DE NORONHA SANTOS GALLO VICTOR MANUEL;DELCLAUX MULLER LUIS. Datos registrales. T 819, L 583, F 130,S 8, H AB 1340, I/A 55 (26.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información