Actos BORME de Crm 10 Soluciones Integrales Sl
25 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: ALBERICH ARJONA JESUS. Datos registrales. T 42243 , F 143, S 8, H M 371461, I/A 14 (18.04.23).
10 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: GUIRADO USANOS BELEN;GUIRADO USANOS BELEN. Datos registrales. T 42243 , F 143, S 8, H M371461, I/A 13 ( 3.03.23).
12 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: HORTELANO LOPEZ JAIME. Revocaciones. Apo.Sol.: HORTELANO LOPEZ JAIME.Nombramientos. Consejero: ANAYA REIG ALBERTO. Apoderado: ANAYA REIG ALBERTO. Cambio de domicilio social. AVDADE MANOTERAS 10 (MADRID). Datos registrales. T 42243 , F 140, S 8, H M 371461, I/A 12 ( 1.12.22).
07 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Como consecuencia del cambio de fecha de cierre del ejerciciosocial se modifica el art铆culo 21. Datos registrales. T 42243 , F 140, S 8, H M 371461, I/A 11 (30.09.22).
18 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: VILCHES DEL HOYO PEDRO ANTONIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GARCIA JOSEJULIO;MASYEBRA SUAREZ LUIS. Apoderado: ALEMANY POZUELO DOLORES. Datos registrales. T 42243 , F 140, S 8, H M371461, I/A 10 (11.02.22).
30 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING SL. Representan: MARTINEZ GARCIA JOSE JULIO.Nombramientos. SecreNoConsj: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA. Consejero: SPREAFICO OLIVIER DOMINIQUE JEAN;VILCHESDEL HOYO PEDRO ANTONIO;BOULANGER FRANCOIS;HORTELANO LOPEZ JAIME. Presidente: SPREAFICO OLIVIERDOMINIQUE JEAN. Apo.Sol.: HORTELANO LOPEZ JAIME. Modificaciones estatutarias. SE ADICCIONA UN NUEVO ARTICULO17潞 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 20949 , F 17, S 8, H M 371461, I/A 9 (23.11.21).
18 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: ALBERICH ARJONA JESUS;GUIRADO USANOS BELEN. Datos registrales. T 20949 , F 16, S 8, HM 371461, I/A 8 (11.11.21).
17 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. AVDA DE SAN LUIS 25 (MADRID). Datos registrales. T 20949 , F 16, S 8, H M 371461, I/A 7(10.10.19).
05 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: ALEMANY POZUELO DOLORES. Datos registrales. T 20949 , F 16, S 8, H M 371461, I/A 6(26.09.12).
08 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: GUIRADO USANOS BELEN. Datos registrales. T 20949 , F 15, S 8, H M 371461, I/A 5 (30.05.12).
21 de Junio de 2010Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING SL. Ceses/Dimisiones. Consejero:MARTINEZ GARCIA JOSE JULIO;MASYEBRA SUAREZ LUIS;HERNANDEZ DEL CASTILLO OLIVARES JOSE VICENTE. Presidente:MARTINEZ GARCIA JOSE JULIO. Vicepresid.: MASYEBRA SUAREZ LUIS. Secretario: ALVAREZ CONTRERAS ANTONIOALFONSO. Nombramientos. Adm. Unico: COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING SL. Representan: MARTINEZ GARCIAJOSE JULIO. Datos registrales. T 20949 , F 15, S 8, H M 371461, I/A 4 ( 8.06.10).